MIGHTY PUB COMPANY LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMIGHTY PUB COMPANY LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04552204
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MIGHTY PUB COMPANY LTD?

    • Lizensierte Restaurants (56101) / Gastgewerbe
    • Gaststätten und Bars (56302) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich MIGHTY PUB COMPANY LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Stables Old Forge Trading Est Dudley Road
    Lye
    DY9 8EL Stourbridge
    West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MIGHTY PUB COMPANY LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MIGHTY PUB COMPANY LTD?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MIGHTY PUB COMPANY LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 01. Sept. 2015

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 13. Aug. 2015

    2 Seiten3.6

    Beendigung der Liquidation

    1 SeitenL64.07

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    2 SeitenCOCOMP

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    4 SeitenRM01

    Beendigung der Bestellung von Eddie Blomqvist als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Abel als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr. Stephen John Abel als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Mats Hartling als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr. Eddie Blomqvist als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Suvi Samuelsson als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 18. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2011

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Suvi Samuelsson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2010

    6 SeitenAA

    Ernennung von Ms. Suvi Samuelsson als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von MIGHTY PUB COMPANY LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HARTLING, Mats
    50 Garfits Lane
    PE21 7EX Boston
    Lincolnshire
    Sekretär
    50 Garfits Lane
    PE21 7EX Boston
    Lincolnshire
    SwedishCompany Director75386090003
    SAMUELSSON, Suvi Paivikki, Ms.
    Station Road
    PE20 2JH Sutterton
    Falstaff House
    Lincolnshire
    Sekretär
    Station Road
    PE20 2JH Sutterton
    Falstaff House
    Lincolnshire
    Swedish129952860001
    UK COMPANY SECRETARIES LIMITED
    11 Church Road
    KT23 3PB Great Bookham
    Surrey
    Bevollmächtigter Sekretär
    11 Church Road
    KT23 3PB Great Bookham
    Surrey
    900013390001
    ABEL, Stephen John
    Dudley Road
    Lye
    DY9 8EL Stourbridge
    The Stables Old Forge Trading Est
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Dudley Road
    Lye
    DY9 8EL Stourbridge
    The Stables Old Forge Trading Est
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director129577470002
    BENNETT, Anthony Edward
    83 Walmley Road
    Walmley
    B76 2QJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    83 Walmley Road
    Walmley
    B76 2QJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishDirector46542430001
    BENNETT, Jason Anthony
    83 Walmley Road
    Walmley
    B76 2QJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    83 Walmley Road
    Walmley
    B76 2QJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishCompany Director20846870001
    BLOMQVIST, Eddie
    Dudley Road
    Lye
    DY9 8EL Stourbridge
    The Stables Old Forge Trading Est
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Dudley Road
    Lye
    DY9 8EL Stourbridge
    The Stables Old Forge Trading Est
    West Midlands
    EnglandSwedishCompany Director183818110001
    BRISTOW, Andrew
    126 Tattershall Road
    PE21 9LR Boston
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    126 Tattershall Road
    PE21 9LR Boston
    Lincolnshire
    United KingdomBritishDirector109011080001
    HARTLING, Mats
    50 Garfits Lane
    PE21 7EX Boston
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    50 Garfits Lane
    PE21 7EX Boston
    Lincolnshire
    United KingdomSwedishCompany Director75386090003
    SAMUELSSON, Suvi Paivikki, Ms.
    Dudley Road
    Lye
    DY9 8EL Stourbridge
    The Stables Old Forge Trading Est
    West Midlands
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Dudley Road
    Lye
    DY9 8EL Stourbridge
    The Stables Old Forge Trading Est
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandSwedishDirector129952860001
    WALKER, Sebastian John
    16 West Street
    PE21 8QH Boston
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    16 West Street
    PE21 8QH Boston
    Lincolnshire
    United KingdomBritishDirector109045410001
    YENIBERTIZ, Yusuf Mehmed
    18 Thomas Middlecot Drive
    PE20 1HU Boston
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    18 Thomas Middlecot Drive
    PE20 1HU Boston
    Lincolnshire
    SwedishCompany Director125923350001
    MARVELLOUS MANAGEMENT LIMITED
    Craythorne Lane
    PE21 6HA Boston
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Craythorne Lane
    PE21 6HA Boston
    Lincolnshire
    125923430001
    UK INCORPORATIONS LIMITED
    11 Church Road
    KT23 3PB Great Bookham
    Surrey
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    11 Church Road
    KT23 3PB Great Bookham
    Surrey
    900013380001

    Hat MIGHTY PUB COMPANY LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal and general charge
    Erstellt am 14. März 2008
    Geliefert am 19. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 2/4 bridge street boston and 23/25 high street boston t/no LL99130 and after dark craythorne lane boston t/no LL133336; other property being interest in any freehold or leasehold property including sale proceeds and any beneficial interest in the property, together with all buildings, fixtures and fittings and all moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment from time to time placed on or used in or about such property as well as any related rights.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 19. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 116. Aug. 2014Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
    • 121. Sept. 2015Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 1
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Apr. 2007
    Geliefert am 03. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    After dark craythorne lane boston t/no LL133336. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juni 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. Aug. 2006
    Geliefert am 09. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    90 southgate sleaford lincolnshire. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juni 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Mai 2006
    Geliefert am 01. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Cactus jacks 23-25 high street and 2/4 bridge street boston lincs. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 01. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juni 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. Mai 2006
    Geliefert am 03. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 03. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juni 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Jan. 2005
    Geliefert am 20. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Nov. 2002
    Geliefert am 03. Dez. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MIGHTY PUB COMPANY LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Steven John Williams
    1 Winckley Court Chapel Street
    PR1 8BU Preston
    Lancashire
    Receiver Manager
    1 Winckley Court Chapel Street
    PR1 8BU Preston
    Lancashire
    David Robert Acland
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    Receiver Manager
    Begbies Traynor
    1 Winckley Court
    PR1 8BU Chapel Street
    Preston
    2
    DatumTyp
    03. Aug. 2015Abschluss der Liquidation
    15. Juli 2014Antragsdatum
    08. Sept. 2014Beginn der Liquidation
    14. Nov. 2015Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or Nottingham
    Level One Apex Court
    City Link
    NG2 4LA Nottingham
    Nottinghamshire
    Praktiker
    Level One Apex Court
    City Link
    NG2 4LA Nottingham
    Nottinghamshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0