FOCUS DIY (INVESTMENTS) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | FOCUS DIY (INVESTMENTS) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04560463 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FOCUS DIY (INVESTMENTS) LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich FOCUS DIY (INVESTMENTS) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 100 Barbirolli Square M2 3EY Manchester Greater Manchester |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FOCUS DIY (INVESTMENTS) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
FOCUS WICKES (INVESTMENTS) LTD | 20. Dez. 2002 | 20. Dez. 2002 |
DE FACTO 1014 LIMITED | 11. Okt. 2002 | 11. Okt. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FOCUS DIY (INVESTMENTS) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 21. Feb. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FOCUS DIY (INVESTMENTS) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 01. Mai 2012 | 27 Seiten | 2.35B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Nov. 2011 | 39 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 96 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 96 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B/2.15B | 9 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr William Grimsey am 13. Mai 2011 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Gawsworth House Westmere Drive Crewe Cheshire CW1 6XB am 11. Mai 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Robbins als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Dawn Michelle Wilkinson am 11. Okt. 2010 | 3 Seiten | CH03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Bird als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Thomas Christopher Morgan am 11. Okt. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Robert Patrick Gladwin am 11. Okt. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Brian Keith Robbins am 11. Okt. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 21. Feb. 2010 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Brian Keith Robbins als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Thomas Christopher Morgan als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Unitt als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Penelope Teale als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 22. Feb. 2009 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FOCUS DIY (INVESTMENTS) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILKINSON, Dawn Michelle | Sekretär | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire United Kingdom | British | 133575310001 | ||||||
GLADWIN, Robert Patrick | Geschäftsführer | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire | United Kingdom | British | Director | 130288970001 | ||||
GRIMSEY, William | Geschäftsführer | 9 The Avenue WD7 7DG Radlett Tall Timbers Hertfordshire | United Kingdom | British | Retailer | 50647840004 | ||||
MORGAN, Thomas Christopher | Geschäftsführer | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire | United Kingdom | British | None | 152428250002 | ||||
HOSKINS, William | Sekretär | 11 Grange Court Road AL5 1BY Harpenden Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 121893830001 | |||||
RIMMER, Barbara | Sekretär | 28 Chapel Lane Hale Barns WA15 0HN Altrincham Cheshire | British | 76973560002 | ||||||
WILLIAMS, David Robert | Sekretär | 15 St Stephens Road CH42 8PP Prenton Merseyside | British | 157062220001 | ||||||
TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 900006100001 | |||||||
ARCHER, William Ernest | Geschäftsführer | The Priory 2 Astley Close WA16 8GJ Knutsford Cheshire | British | Director | 15170380004 | |||||
BIRD, Richard Sidney | Geschäftsführer | 80 Wolsey Road HA6 2EH Northwood Middlesex | United Kingdom | British | Director | 111500210002 | ||||
HOSKINS, William | Geschäftsführer | 11 Grange Court Road AL5 1BY Harpenden Hertfordshire | British | Chartered Accountant | 121893830001 | |||||
JOHNSON, Stephen Richard | Geschäftsführer | The Old Vicarage Lower Dunsforth YO26 9SA York | England | British | Director | 87398750001 | ||||
ROBBINS, Brian Keith | Geschäftsführer | Westmere Drive CW1 6XB Crewe Gawsworth House Cheshire | United Kingdom | American | None | 153559370002 | ||||
TEALE, Penelope Jane | Geschäftsführer | 1 Weldon Rise Off Pitcher Lane MK5 8BW Loughton Milton Keynes | United Kingdom | British | Director | 126053080001 | ||||
THOMAS, Shelley Frances | Geschäftsführer | Everest Road SK14 4DX Hyde Woodside Farm Cheshire | United Kingdom | British | Director | 133244600001 | ||||
UNITT, Andrew Vaughan | Geschäftsführer | 64 Main Street LE74 4UU Cossington Hollycroft Leicester | England | British | Chief Financial Officer | 182500750001 | ||||
WEST, Gary James | Geschäftsführer | Merlewood House Russell Road TW17 8JS Shepperton Middlesex | United Kingdom | British | Director | 127476430001 | ||||
WILLIAMS, David Robert | Geschäftsführer | 15 St Stephens Road CH42 8PP Prenton Merseyside | United Kingdom | British | Director | 157062220001 | ||||
WILSON, Geoffrey Charles | Geschäftsführer | Broadoaks 237 Seabridge Lane ST5 3TB Newcastle Under Lyme Staffordshire | British | Director | 72996700001 | |||||
TRAVERS SMITH LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 900006090001 | |||||||
TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 900006100001 |
Hat FOCUS DIY (INVESTMENTS) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A keyman insurance assignment | Erstellt am 12. Mai 2006 Geliefert am 18. Mai 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The security assets meaning each policy and its related policy benefits. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mezzanine debenture | Erstellt am 03. März 2005 Geliefert am 10. März 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 16. Feb. 2005 Geliefert am 25. Feb. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Subordinated debenture | Erstellt am 16. Feb. 2005 Geliefert am 25. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A mezzanine debenture | Erstellt am 28. Juli 2003 Geliefert am 13. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the issuer and each of the other guarantors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Subordinated debenture | Erstellt am 29. Nov. 2002 Geliefert am 14. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Nov. 2002 Geliefert am 14. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company and each of the other obligors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat FOCUS DIY (INVESTMENTS) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0