E REALISATIONS 2020 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameE REALISATIONS 2020 LIMITED
    UnternehmensstatusIn Verwaltung
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04566809
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von E REALISATIONS 2020 LIMITED?

    • Verglasung (43342) / Bauwesen

    Wo befindet sich E REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von E REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EVEREST LIMITED01. Mai 200301. Mai 2003
    EVER 1950 LIMITED18. Okt. 200218. Okt. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von E REALISATIONS 2020 LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. März 2020
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. März 2021
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für E REALISATIONS 2020 LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis18. Okt. 2020
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung29. Nov. 2020
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis18. Okt. 2019
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für E REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    30 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    30 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    30 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    30 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    30 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    15 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    31 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    31 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    30 SeitenAM10

    Beendigung der Bestellung von John Bostock als Geschäftsführer am 14. Aug. 2020

    1 SeitenTM01

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    3 SeitenAM06

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA

    14 SeitenAM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Everest House Sopers Road, Cuffley Potters Bar Hertfordshire EN6 4SG zum 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU am 06. Juli 2020

    2 SeitenAD01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 09. Juni 2020

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Vorschlag des Verwalters

    60 SeitenAM03

    Ernennung eines Verwalters

    3 SeitenAM01

    Änderung der Details des Sekretärs für Estera Administration (Uk) Limited am 01. Apr. 2020

    1 SeitenCH04

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2019 bis 31. März 2020

    1 SeitenAA01

    Beendigung der Bestellung von Karl Sean Munns als Geschäftsführer am 18. Okt. 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 18. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    37 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von E REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    OCORIAN ADMINISTRATION (UK) LIMITED
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28 Eastcastle Street
    England
    Sekretär
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28 Eastcastle Street
    England
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer07473349
    174130020003
    LEIGHTON, Richard Mathieu
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Geschäftsführer
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandDutchDirector183503870001
    JARMAN, Simon James
    1 Swanley Bar Lane
    EN6 1NN Potters Bar
    Hertfordshire
    Sekretär
    1 Swanley Bar Lane
    EN6 1NN Potters Bar
    Hertfordshire
    BritishDirector65100170002
    SMETHURST, Edward Gerald
    Salthill Road
    BB7 1PE Clitheroe
    Enterprise Works
    Lancashire
    United Kingdom
    Sekretär
    Salthill Road
    BB7 1PE Clitheroe
    Enterprise Works
    Lancashire
    United Kingdom
    BritishSolicitor86741880002
    WARWICK-SAUNDERS, Richard Meirion
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Sekretär
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    168812940001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    HERITAGE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28
    England
    Sekretär
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28
    England
    174130020001
    ASPLIN, Robert Alexander
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector149870270004
    BLAND, Duncan
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector87382460002
    BOSTOCK, John
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Geschäftsführer
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    United KingdomBritishDirector27964350001
    DAYAN, Daniel Alexander
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector114867990002
    EADY, Roy Thomas
    Maylands Mill Hill
    Shenfield
    CM15 8EU Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    Maylands Mill Hill
    Shenfield
    CM15 8EU Brentwood
    Essex
    EnglandBritishDirector3078230001
    FAWCETT, Christopher Stephen
    86 Kings Road
    TW10 6EE Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    86 Kings Road
    TW10 6EE Richmond
    Surrey
    BritishDirector81019930002
    FROST, Roy Anthony
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector169351970001
    GARDINER, Stephen James Furse
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    Gb-EngBritishCompany Director76915750003
    HOLLAND, Joanne Maria
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish,AustralianDirector74549980001
    HOPLEY, Mark Simon Griffith
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant105670800002
    JARMAN, Simon James
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector65100170002
    JORDAN, Alan James
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandIrishAccountant150320720001
    LAMBERT, Andrew Alan
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritishOperations Director163093150001
    LEIGHTON, Richard Mathieu
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandDutchDirector183503870005
    MCGRATH, William Brendan
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director9583140003
    MOTTERSHEAD, Peter David Leigh
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector102140470001
    MUNNS, Karl Sean
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector233273680001
    PARSELL, Antony Clive
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandEnglishDirector76298010001
    RISLEY, Gary Alexander
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector170454400001
    SANDERS, Nicholas Ian Burgess
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritishOperator83283880002
    SAUNDERS, Roy
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector144563690001
    STANWAY, Andrew David
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United Kingdom British Director31199160002
    TROUGHTON, Martin
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector146281880001
    WILLIAMSON, Peter John
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritishOperator152256060003
    WOLSTENHOLME, Adrian John
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant130602430004
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023520001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei E REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer08004858
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat E REALISATIONS 2020 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 09. Mai 2018
    Geliefert am 22. Mai 2018
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    F/H land at treherbert industrial estate rhondda south wales t/no WA244458 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • BECAP12 Gp Limited in Its Capacity as General Partner of BECAP12 Gp LP in Its Capacity as General Partner of Becap 12 Fund LP
    Transaktionen
    • 22. Mai 2018Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 27. März 2015
    Geliefert am 08. Apr. 2015
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Land at treherbert industrial estate treherbert treorchy t/no WA244458.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    Debenture
    Erstellt am 19. Juni 2012
    Geliefert am 28. Juni 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H treherbert industrial estate, rhondda, south wales, t/no: wa 244458. l/h unit 7, north orbital commercial park, hertfordshire, t/no: HD438566; and l/h everest house sopers road, cuffley, potters bar, t/no: HD477923. (For details of all other property charged, please refer to the MG01 document). Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • BECAP12 Gp Limited
    Transaktionen
    • 28. Juni 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 25. Apr. 2012
    Geliefert am 30. Apr. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • BECAP12 Fund LP
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 20. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 2012
    Geliefert am 11. Apr. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 09. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 08. Nov. 2011
    Geliefert am 21. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any one or more of the principals or the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sum standing to the credit of an account whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 09. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 29. Apr. 2009
    Geliefert am 01. Mai 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Jcb c/w 9" 12" & dm buckets. Cd summer electrical x 14 high bay lights 400W metal handle fitting. Rojak design x 50 stopper foot/extender left (for details of further chattels charged please refer to form 395) see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 01. Mai 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 04. Sept. 2007
    Geliefert am 14. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Apr. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of deposit
    Erstellt am 14. Apr. 2005
    Geliefert am 16. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Rent deposit balance (initial amount £17,670) and accrued interest.
    Berechtigte Personen
    • Coal Pension Properties Limited
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 28. Nov. 2003
    Geliefert am 09. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All of the right title and interest from time to time of the company in the equipment specified in the schedule to the mortgage.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Apr. 2003
    Geliefert am 25. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H treherbert industrial estate treherbert mid glam t/n WA244458. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Apr. 2003
    Geliefert am 25. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Security Trustee for the Security Beneficiaries) (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat E REALISATIONS 2020 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Juni 2020Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Geoffrey Paul Rowley
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praktiker
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Alastair Massey
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praktiker
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0