PARTHENON PROJECTS (NEW HOMES) LIMITED

PARTHENON PROJECTS (NEW HOMES) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePARTHENON PROJECTS (NEW HOMES) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04568487
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PARTHENON PROJECTS (NEW HOMES) LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich PARTHENON PROJECTS (NEW HOMES) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Oury Clark
    Herschel House
    SL1 1HD 58 Herschel Street Slough
    Berkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PARTHENON PROJECTS (NEW HOMES) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2004

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PARTHENON PROJECTS (NEW HOMES) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für PARTHENON PROJECTS (NEW HOMES) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung

    1 Seiten4.43

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 12. Nov. 2009

    3 Seiten3.6

    legacy

    1 SeitenLQ02

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 24. Feb. 2009

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 24. Feb. 2009

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers

    3 Seiten3.6

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Liquidators

    1 Seiten4.31

    Gerichtsbeschluss zur Liquidation

    3 SeitenCOCOMP

    Verschiedenes

    Form 3.2 - statement of affairs
    17 SeitenMISC

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    9 Seiten3.10

    Verschiedenes

    Statement of affairs
    4 SeitenMISC

    Bericht des Verwaltungsverwalters

    7 Seiten3.10

    legacy

    1 Seiten287

    Verschiedenes

    Amended form 405(1)
    2 SeitenMISC

    legacy

    2 Seiten405(1)

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    4 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2004

    5 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von PARTHENON PROJECTS (NEW HOMES) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CUNNINGHAM, Jason Paul
    1 Oakwood Close
    BH24 2JD Ashley Heath
    Dorset
    Geschäftsführer
    1 Oakwood Close
    BH24 2JD Ashley Heath
    Dorset
    British65961800002
    FAIRHALL, Mary Elizabeth
    133 Wimborne Road
    BH15 2BG Poole
    Dorset
    Sekretär
    133 Wimborne Road
    BH15 2BG Poole
    Dorset
    British85341000001
    GARDNER, Roy Harold
    7 Willow Brook
    Middleton On Sea
    PO22 6PD Bognor Regis
    West Sussex
    Sekretär
    7 Willow Brook
    Middleton On Sea
    PO22 6PD Bognor Regis
    West Sussex
    British2990630002
    PHILLIPS, Roy John
    61 East Avenue
    Talbot Woods
    BH3 7BT Bournemouth
    Dorset
    Sekretär
    61 East Avenue
    Talbot Woods
    BH3 7BT Bournemouth
    Dorset
    British76921420002
    WAYNE, Harold
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    British900005490001
    PHILLIPS, Roy John
    61 East Avenue
    Talbot Woods
    BH3 7BT Bournemouth
    Dorset
    Geschäftsführer
    61 East Avenue
    Talbot Woods
    BH3 7BT Bournemouth
    Dorset
    British76921420002
    SPENCER, Ronald James
    32 Budmouth Avenue
    DT3 6JP Preston
    Dorset
    Geschäftsführer
    32 Budmouth Avenue
    DT3 6JP Preston
    Dorset
    British102094890001
    WAYNE, Yvonne
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Burlington House
    40 Burlington Rise
    EN4 8NN East Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritish900005480001

    Hat PARTHENON PROJECTS (NEW HOMES) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2004
    Geliefert am 29. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the north west of royal fisheries house avon buildings christchurch dorset t/no DT313573. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 2004
    Geliefert am 29. Dez. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land adjacent to royality fisheries house avon buildings christchurch dorset t/no DT3135473.
    Berechtigte Personen
    • John Oak
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 29. März 2004
    Geliefert am 14. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £790,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 60 kings avenue lower parkstone poole dorset BH14 9QJ. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Second legal charge
    Erstellt am 29. März 2004
    Geliefert am 14. Apr. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £200,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H land and property 60 kings avenue lower parkstone poole dorset.
    Berechtigte Personen
    • Bryan Lawrence Morgan
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 2003
    Geliefert am 06. Juni 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £236,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and property k/a 61 woolsbridge road ashley heath ringwood hampshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Dez. 2002
    Geliefert am 27. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £1,000,000.00 due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The moorings,13 wortley road,highcliffe,christchurch,dorset BH23 5DR.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 09. Dez. 2002
    Geliefert am 24. Dez. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 2005Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 107. Dez. 2009Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 1

    Hat PARTHENON PROJECTS (NEW HOMES) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Dez. 2002Instrumentendatum
    Administrativer Receiver bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Michael David Gercke
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Robert William Birchall
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praktiker
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    2
    DatumTyp
    05. Aug. 2014Abschluss der Liquidation
    30. Sept. 2005Antragsdatum
    24. Nov. 2005Beginn der Liquidation
    14. Nov. 2014Aufgelöst am
    Zwangsliquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    The Official Receiver Or Bournemouth
    3rd Floor
    Richmond House
    BH2 6EZ Richmond Hill
    Bournemouth
    Praktiker
    3rd Floor
    Richmond House
    BH2 6EZ Richmond Hill
    Bournemouth
    Elliot H Green
    Oury Clark
    Herschel House
    SL1 1PG 58 Herschel Street
    Slough Berkshire
    Praktiker
    Oury Clark
    Herschel House
    SL1 1PG 58 Herschel Street
    Slough Berkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0