KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04569223
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Estate Office
    Oakley House
    MK43 7ST Oakley
    Bedfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    STEELRAY NO. 194 LIMITED22. Okt. 200222. Okt. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2022

    Welche sind die letzten Einreichungen für KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Paul Simon Fernback als Geschäftsführer am 31. Dez. 2023

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Alan Geoffrey Fernback als Geschäftsführer am 31. Dez. 2023

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2023 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2022

    11 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 045692230011 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2022 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2021

    11 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2021 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2020

    12 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    2 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2020 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2019

    12 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Eintragung der Belastung 045692230011, erstellt am 25. Feb. 2019

    5 SeitenMR01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2018

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    10 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Geprüfte Jahresabschluss, gekürzt, bis 30. Sept. 2016

    9 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Toni Brook als Sekretär am 24. Okt. 2016

    1 SeitenTM02

    Wer sind die Geschäftsführer von KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HUNT, Sharon Anne
    Oakley House
    Oakley House
    MK43 7ST Bedford
    Estate Office
    Bedfordshire
    England
    Sekretär
    Oakley House
    Oakley House
    MK43 7ST Bedford
    Estate Office
    Bedfordshire
    England
    217622840001
    LOUSADA, Simon Charles
    Oakley
    MK43 7ST Bedford
    Oakley House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Oakley
    MK43 7ST Bedford
    Oakley House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish16199140003
    BROOK, Toni
    Oakley House
    MK43 7ST Oakley
    Estate Office
    Bedfordshire
    England
    Sekretär
    Oakley House
    MK43 7ST Oakley
    Estate Office
    Bedfordshire
    England
    174438760001
    LOUSADA, Charles Terence
    Estate Office Crawley Park
    MK42 0UU Husborne Crawley
    Bedford
    Sekretär
    Estate Office Crawley Park
    MK42 0UU Husborne Crawley
    Bedford
    British94444470001
    STEELRAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    43 Richmond Hill
    BH2 6LR Bournemouth
    Richmond Point
    Dorset
    Sekretär
    43 Richmond Hill
    BH2 6LR Bournemouth
    Richmond Point
    Dorset
    60731070001
    FERNBACK, Alan Geoffrey
    20 Park Avenue
    Farnborough Park
    BR6 8LL Orpington
    The Tudors
    Kent
    Geschäftsführer
    20 Park Avenue
    Farnborough Park
    BR6 8LL Orpington
    The Tudors
    Kent
    EnglandBritish38497170001
    FERNBACK, Paul Simon
    20 Park Avenue
    Farnborough
    BR6 8LL Orpington
    Kent
    Geschäftsführer
    20 Park Avenue
    Farnborough
    BR6 8LL Orpington
    Kent
    United KingdomBritish58655410001
    LOUSADA, Charles Terence
    Estate Office Crawley Park
    MK42 0UU Husborne Crawley
    Bedford
    Geschäftsführer
    Estate Office Crawley Park
    MK42 0UU Husborne Crawley
    Bedford
    EnglandBritish94444470001
    TYRRELL, Brinley George
    Coton House
    Clay Coton
    NN6 6JU Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Coton House
    Clay Coton
    NN6 6JU Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish141886210001
    STEELE NOMINEES LTD
    Richmond Point
    43 Richmond Hill
    BH2 6LR Bournemouth
    Dorset
    Geschäftsführer
    Richmond Point
    43 Richmond Hill
    BH2 6LR Bournemouth
    Dorset
    103417250001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Euroway Homes Limited
    W1S 1DE London
    70-71 New Bond Street
    London
    United Kingdom
    03. Mai 2016
    W1S 1DE London
    70-71 New Bond Street
    London
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLtd
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageEngland & Wales
    Registrierungsort70-71 New Bond Street, London
    Registrierungsnummer02265680
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    Lousada Investments Limited
    Oakley House
    MK43 7ST Oakley
    The Estate Office
    Bedfordshire
    England
    03. Mai 2016
    Oakley House
    MK43 7ST Oakley
    The Estate Office
    Bedfordshire
    England
    Nein
    RechtsformLimited
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageEngland & Wales
    RegistrierungsortEstate Office, Oakley House, Oakley, Beds, Uk
    Registrierungsnummer09221425
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 25. Feb. 2019
    Geliefert am 06. März 2019
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. März 2019Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 16. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Okt. 2006
    Geliefert am 13. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the north and east sides of clensmore street kidderminster t/nos HW96027 WR48934 and WR47900. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Okt. 2006
    Geliefert am 13. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings and the south east side of churchfields kidderminster t/n WR83405. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juni 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Okt. 2006
    Geliefert am 13. Okt. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The unicorn inn broad street kidderminster t/n WR88487. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Juni 2004
    Geliefert am 08. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over property known as units 23-26 churchfields business park clensmore street kidderminster worcestershire DY10 2JS with title number HW96027. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Apr. 2004
    Geliefert am 07. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as the unicorn inn broad street kidderminster. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Nov. 2003
    Geliefert am 28. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Churchfields kidderminster worcestershire t/n's WR72007, HW120256, HW200809 and WR52572. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Nov. 2003
    Geliefert am 04. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,075,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H land at churchfields, kidderminster, wyre forest, worcestershire t/no WR72007 and HW120256 and HW200809 and WR53572.
    Berechtigte Personen
    • Cms (Kidderminster) Limited
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Mai 2003
    Geliefert am 08. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the east side of clensmore street, kidderminster t/n's WR47900 and WR48934. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. März 2003
    Geliefert am 15. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property shown for the purposes of identification only edged red on plan 1 attached to the transfer dated 10TH march 2003 between the company and tomkinsons carpets limited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. März 2003
    Geliefert am 15. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All land and buildings on the east side of clensmore street kidderminster with title numbers WR57900 and WR48934. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0