KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04569223 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Estate Office Oakley House MK43 7ST Oakley Bedfordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| STEELRAY NO. 194 LIMITED | 22. Okt. 2002 | 22. Okt. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul Simon Fernback als Geschäftsführer am 31. Dez. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Alan Geoffrey Fernback als Geschäftsführer am 31. Dez. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2023 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2022 | 11 Seiten | AA | ||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 045692230011 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2021 | 11 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2020 | 12 Seiten | AA | ||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 12 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Eintragung der Belastung 045692230011, erstellt am 25. Feb. 2019 | 5 Seiten | MR01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 10 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 10 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||
Geprüfte Jahresabschluss, gekürzt, bis 30. Sept. 2016 | 9 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Toni Brook als Sekretär am 24. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNT, Sharon Anne | Sekretär | Oakley House Oakley House MK43 7ST Bedford Estate Office Bedfordshire England | 217622840001 | |||||||
| LOUSADA, Simon Charles | Geschäftsführer | Oakley MK43 7ST Bedford Oakley House Bedfordshire United Kingdom | England | British | 16199140003 | |||||
| BROOK, Toni | Sekretär | Oakley House MK43 7ST Oakley Estate Office Bedfordshire England | 174438760001 | |||||||
| LOUSADA, Charles Terence | Sekretär | Estate Office Crawley Park MK42 0UU Husborne Crawley Bedford | British | 94444470001 | ||||||
| STEELRAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 43 Richmond Hill BH2 6LR Bournemouth Richmond Point Dorset | 60731070001 | |||||||
| FERNBACK, Alan Geoffrey | Geschäftsführer | 20 Park Avenue Farnborough Park BR6 8LL Orpington The Tudors Kent | England | British | 38497170001 | |||||
| FERNBACK, Paul Simon | Geschäftsführer | 20 Park Avenue Farnborough BR6 8LL Orpington Kent | United Kingdom | British | 58655410001 | |||||
| LOUSADA, Charles Terence | Geschäftsführer | Estate Office Crawley Park MK42 0UU Husborne Crawley Bedford | England | British | 94444470001 | |||||
| TYRRELL, Brinley George | Geschäftsführer | Coton House Clay Coton NN6 6JU Northampton Northamptonshire | England | British | 141886210001 | |||||
| STEELE NOMINEES LTD | Geschäftsführer | Richmond Point 43 Richmond Hill BH2 6LR Bournemouth Dorset | 103417250001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euroway Homes Limited | 03. Mai 2016 | W1S 1DE London 70-71 New Bond Street London United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Lousada Investments Limited | 03. Mai 2016 | Oakley House MK43 7ST Oakley The Estate Office Bedfordshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 25. Feb. 2019 Geliefert am 06. März 2019 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Okt. 2006 Geliefert am 13. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land on the north and east sides of clensmore street kidderminster t/nos HW96027 WR48934 and WR47900. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Okt. 2006 Geliefert am 13. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings and the south east side of churchfields kidderminster t/n WR83405. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 06. Okt. 2006 Geliefert am 13. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The unicorn inn broad street kidderminster t/n WR88487. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Juni 2004 Geliefert am 08. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Legal mortgage over property known as units 23-26 churchfields business park clensmore street kidderminster worcestershire DY10 2JS with title number HW96027. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Apr. 2004 Geliefert am 07. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property known as the unicorn inn broad street kidderminster. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Nov. 2003 Geliefert am 28. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Churchfields kidderminster worcestershire t/n's WR72007, HW120256, HW200809 and WR52572. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Nov. 2003 Geliefert am 04. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,075,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben F/H land at churchfields, kidderminster, wyre forest, worcestershire t/no WR72007 and HW120256 and HW200809 and WR53572. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Mai 2003 Geliefert am 08. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the east side of clensmore street, kidderminster t/n's WR47900 and WR48934. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. März 2003 Geliefert am 15. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property shown for the purposes of identification only edged red on plan 1 attached to the transfer dated 10TH march 2003 between the company and tomkinsons carpets limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. März 2003 Geliefert am 15. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All land and buildings on the east side of clensmore street kidderminster with title numbers WR57900 and WR48934. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0