CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD
Überblick
| Unternehmensname | CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04575157 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD?
- Lizensierte Restaurants (56101) / Gastgewerbe
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 20 Coxon Street Spondon DE21 7JG Derby Derbyshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Okt. 2015 bis 30. Apr. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Leah Werjuka als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Isidor Heller als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 2Nd Floor Saxon House Heritage Gate Friary Street Derby DE1 1NL* am 21. Okt. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WERJUKA, Leah | Sekretär | Granville Road NW2 2LD London 168 United Kingdom | 179212550001 | |||||||
| WERJUKA, Abraham Isaac | Geschäftsführer | 168 Granville Rd NW2 2LD London | United Kingdom | English | 85279930001 | |||||
| HELLER, Isidor | Sekretär | 168 Granville Road NW2 2LD London | British | 11855180003 | ||||||
| @UKPLC CLIENT SECRETARY LTD | Bevollmächtigter Sekretär | 5, Jupiter House Calleva Park, Aldermaston RG7 8NN Reading | 900025730001 | |||||||
| HELLER, Isidor | Geschäftsführer | 76 Woodlands NW11 9QU London | Uk | 85368090001 | ||||||
| @UKPLC CLIENT DIRECTOR LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 5, Jupiter House Calleva Park, Aldermaston RG7 8NN Reading | 900025720001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Abraham Isaac Werjuka | 06. Apr. 2016 | Hendon NW4 2NG London 22 Green Lane | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat CITY CENTRE ESTATES (LEISURE) LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rent charge agreement | Erstellt am 25. Juni 2012 Geliefert am 28. Juni 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All gross rents, licence fees and other monies receivable now or in the future see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security executed on 3 april 2011 | Erstellt am 16. Mai 2011 Geliefert am 19. Mai 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from abraham isaac werjuka to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and whole that area of ground k/a shore park forming part of latheronwheel mains caithness in the county of caithness t/no. CTH2887 together with buildings and erections in and upon the said area of ground see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security executed on 3 april 2011 | Erstellt am 16. Mai 2011 Geliefert am 19. Mai 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from abraham isaac werjuka to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and whole that area of ground extending to three hundred and thirty decimal or one thousandth parts of an acre or thereby lying on the south east side of the trunk road A9 leading from lybster to dunbeath and situated in the village of latheronwheel and county of caithness together with the dwellinghouse k/a craiglea and all other buildings and erections on the said ground see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Juli 2007 Geliefert am 10. Juli 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 05/07/07 and | Erstellt am 26. Juni 2007 Geliefert am 12. Juli 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and whole that area of groun k/a shore park extending to 55.30 hectares or thereby forming part of latheronwheel mains caithness in the county of caithness. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 05/07/07 and | Erstellt am 15. März 2007 Geliefert am 12. Juli 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and whole that area of ground extending to three hundred and thirty decimal or one thoudsansth part of an acre or thereby lying on the south east side of the trunk road A9 leading from lybster to dunbeath and situated in the village of latheronwheel and county of caithness together with the dwelling house K.a "craiglea" and all buildings and erections therein. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture containing fixed and floating charges | Erstellt am 18. Nov. 2002 Geliefert am 19. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 29TH november 2002 and | Erstellt am 15. Nov. 2002 Geliefert am 07. Dez. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Area of ground together with the property k/a "craiglea" and all other buildings erections on the south east side of the A9 leading from lybster to dunbeath situated in the village of latheronwheel and county of caithness. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0