ENGINEERING SERVICES (FASTENERS) LIMITED

ENGINEERING SERVICES (FASTENERS) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameENGINEERING SERVICES (FASTENERS) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04585763
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ENGINEERING SERVICES (FASTENERS) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich ENGINEERING SERVICES (FASTENERS) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Hale House
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    East Sussex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ENGINEERING SERVICES (FASTENERS) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EVERSOCIAL LIMITED08. Nov. 200208. Nov. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENGINEERING SERVICES (FASTENERS) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2022

    Welche sind die letzten Einreichungen für ENGINEERING SERVICES (FASTENERS) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022

    7 SeitenAA

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2023 bis 31. Dez. 2022

    1 SeitenAA01

    Beendigung der Bestellung von Graham Alan Smith als Geschäftsführer am 29. Juni 2022

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Graham Alan Smith als Sekretär am 29. Juni 2022

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Christopher Brown als Direktor am 29. Juni 2022

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Kevin Mccarthy als Direktor am 29. Juni 2022

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Kevin Godin als Direktor am 29. Juni 2022

    2 SeitenAP01

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Change of details for Tfc Europe Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC05

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juni 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017

    7 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Martin Hugh Clarke als Geschäftsführer am 06. Dez. 2017

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von ENGINEERING SERVICES (FASTENERS) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BROWN, Christopher James
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    Hale House
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    Hale House
    East Sussex
    United StatesAmericanDirector297510400001
    BURGOYNE, Morgan
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    Hale House
    East Sussex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    Hale House
    East Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector57934930001
    GODIN, Kevin
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    Hale House
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    Hale House
    East Sussex
    United StatesAmericanDirector297511870001
    MCCARTHY, Kevin
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    Hale House
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    Hale House
    East Sussex
    United StatesAmericanDirector297510090001
    BULL, Tony Lewis
    Tandshouse 2 Gilstead Court
    Warren Lane Gilstead
    BD16 3LA Bingley
    West Yorkshire
    Sekretär
    Tandshouse 2 Gilstead Court
    Warren Lane Gilstead
    BD16 3LA Bingley
    West Yorkshire
    BritishEngineer86778470001
    SMITH, Graham Alan
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    Hale House
    East Sussex
    United Kingdom
    Sekretär
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    Hale House
    East Sussex
    United Kingdom
    British165938960001
    RWL REGISTRARS LIMITED
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    Bevollmächtigter Sekretär
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    900007870001
    BULL, Tony Lewis
    Tandshouse 2 Gilstead Court
    Warren Lane Gilstead
    BD16 3LA Bingley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Tandshouse 2 Gilstead Court
    Warren Lane Gilstead
    BD16 3LA Bingley
    West Yorkshire
    EnglandBritishEngineer86778470001
    CLARKE, Martin Hugh
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    Hale House
    East Sussex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    Hale House
    East Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector72992490005
    SMITH, Graham Alan
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    Hale House
    East Sussex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    Hale House
    East Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant134862240001
    WILSON, John
    1 Moorside Walk
    Drighlington
    BD11 1HL Bradford
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    1 Moorside Walk
    Drighlington
    BD11 1HL Bradford
    West Yorkshire
    EnglandBritishSalesman58794080001
    BONUSWORTH LIMITED
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    39406570001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ENGINEERING SERVICES (FASTENERS) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Tfc Europe Limited
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    Hale House
    East Sussex
    England
    06. Apr. 2016
    Ghyll Industrial Estate
    TN21 8AW Heathfield
    Hale House
    East Sussex
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat ENGINEERING SERVICES (FASTENERS) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    All assets debenture
    Erstellt am 14. Nov. 2011
    Geliefert am 16. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 16. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 26. Mai 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 03. Nov. 2011
    Geliefert am 17. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other investors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Foresight 2 Vct PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 26. Mai 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Nov. 2011
    Geliefert am 08. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a eastwood works parson street keighley west yorkshire t/no. WYK408897 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 13. Juni 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 03. Nov. 2011
    Geliefert am 05. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 29. Juni 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 13. Sept. 2009
    Geliefert am 24. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Commercial Finance LTD
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Sept. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 16. Okt. 2008
    Geliefert am 18. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a land on the north east side of parson street keighley west yorkshire t/no. WYK408897 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Nov. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 07. Jan. 2003
    Geliefert am 10. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as eversocial limited to the chargee now known as chartwell keighley limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets of the company present and future including goodwill bookdebts and uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Engineering Services (Fasteners) Limited
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Dez. 2002
    Geliefert am 08. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Nov. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0