TLLC PROPHOLDCO2 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TLLC PROPHOLDCO2 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04588793 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TLLC PROPHOLDCO2 LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TLLC PROPHOLDCO2 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TLLC PROPHOLDCO2 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
VIOLETBAY LIMITED | 13. Nov. 2002 | 13. Nov. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TLLC PROPHOLDCO2 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TLLC PROPHOLDCO2 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 18 Seiten | 4.71 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Grant David Hearn als Geschäftsführer am 25. Nov. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Duff & Phelps Ltd 43-45 Portman Square London W1H 6LY am 22. Juli 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jon William Mortimore als Geschäftsführer am 28. März 2013 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jon William Mortimore als Sekretär am 28. März 2013 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB am 20. Dez. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Guy Paul Cuthbert Parsons als Geschäftsführer am 20. Apr. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 18 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Paul Victor Harvey am 03. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Guy Paul Cuthbert Parsons am 03. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Grant David Hearn am 03. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Jon William Mortimore am 03. Feb. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Jon William Mortimore am 03. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 16 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TLLC PROPHOLDCO2 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||
HARVEY, Paul Victor | Geschäftsführer | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 116809270002 | ||||
HICKS, Christopher Michael | Sekretär | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | Accountant | 53932930001 | |||||
JACKSON, Kevin David | Sekretär | Field House 147 Main Street Sutton Bonington LE12 5PE Loughborough | British | Property Director | 141586330001 | |||||
MORTIMORE, Jon William | Sekretär | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | British | Company Director | 93906210001 | |||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
TRAVELREST SERVICES LIMITED | Sekretär | Parklands Court 24 Parklands Birmingham Great Park Rubery B45 9PZ Birmingham West Midlands | 42204690005 | |||||||
HEARN, Grant David | Geschäftsführer | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | England | British | Company Director | 88628480002 | ||||
HICKS, Christopher Michael | Geschäftsführer | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | Accountant | 53932930001 | |||||
JACKSON, Kevin David | Geschäftsführer | Field House 147 Main Street Sutton Bonington LE12 5PE Loughborough | England | British | Property Director | 141586330001 | ||||
LAYTON, Matthew Robert | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
MORTIMORE, Jon William | Geschäftsführer | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 93906210001 | ||||
PARSONS, Guy Paul Cuthbert | Geschäftsführer | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 102187770002 | ||||
RICHARDS, Martin Edgar | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
SCOBLE, Timothy James | Geschäftsführer | 57 Old Road Wheatley OX33 1NX Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 83743120001 | ||||
STOREY, Mark | Geschäftsführer | 11 Ripon Street HP20 2JP Aylesbury Buckinghamshire | British | Director Of Treasury & Corpora | 121960950001 | |||||
TURL, Simon Charles | Geschäftsführer | Arden House Eastwell Road LE14 4SS Scalford Leicestershire | British | Director | 80261230001 | |||||
TURNER, Harry | Geschäftsführer | Shepherds Cottage The Vale Golf & Country Club Bishampton Fields WR10 2LZ Bishampton Near Pershore Worcestershire | England | British | Chief Operating Officer | 166789700001 |
Hat TLLC PROPHOLDCO2 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 09. Nov. 2006 Geliefert am 18. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Feb. 2003 Geliefert am 18. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money or liabilities whatsoever due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Feb. 2003 Geliefert am 18. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money or liabilities whatsoever due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Feb. 2003 Geliefert am 12. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat TLLC PROPHOLDCO2 LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0