TLLC DEVCO1 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TLLC DEVCO1 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04588941 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TLLC DEVCO1 LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich TLLC DEVCO1 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TLLC DEVCO1 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| VIOLETDRIVE LIMITED | 13. Nov. 2002 | 13. Nov. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TLLC DEVCO1 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TLLC DEVCO1 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 18 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Guy Paul Cuthbert Parsons am 03. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Paul Victor Harvey am 03. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Grant David Hearn am 03. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Jon William Mortimore am 03. Feb. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Jon William Mortimore am 03. Feb. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 3 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 10 Seiten | 395 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TLLC DEVCO1 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORTIMORE, Jon William | Sekretär | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | British | 93906210001 | ||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||
| HARVEY, Paul Victor | Geschäftsführer | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | 116809270002 | |||||
| HEARN, Grant David | Geschäftsführer | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | England | British | 88628480002 | |||||
| MORTIMORE, Jon William | Geschäftsführer | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | 93906210001 | |||||
| PARSONS, Guy Paul Cuthbert | Geschäftsführer | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | 102187770002 | |||||
| HICKS, Christopher Michael | Sekretär | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | 53932930001 | ||||||
| JACKSON, Kevin David | Sekretär | Field House 147 Main Street Sutton Bonington LE12 5PE Loughborough | British | 141586330001 | ||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| TRAVELREST SERVICES LIMITED | Sekretär | Parklands Court 24 Parklands Birmingham Great Park Rubery B45 9PZ Birmingham West Midlands | 42204690005 | |||||||
| HICKS, Christopher Michael | Geschäftsführer | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | 53932930001 | ||||||
| JACKSON, Kevin David | Geschäftsführer | Field House 147 Main Street Sutton Bonington LE12 5PE Loughborough | England | British | 141586330001 | |||||
| LAYTON, Matthew Robert | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
| SCOBLE, Timothy James | Geschäftsführer | 57 Old Road Wheatley OX33 1NX Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 83743120001 | |||||
| TURL, Simon Charles | Geschäftsführer | Arden House Eastwell Road LE14 4SS Scalford Leicestershire | British | 80261230001 | ||||||
| TURNER, Harry | Geschäftsführer | Shepherds Cottage The Vale Golf & Country Club Bishampton Fields WR10 2LZ Bishampton Near Pershore Worcestershire | England | British | 166789700001 |
Hat TLLC DEVCO1 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 09. Nov. 2006 Geliefert am 18. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental leverage debenture | Erstellt am 27. Mai 2003 Geliefert am 12. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor or other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights title and interest in the development agreement between travelodge services limited and the chargor and the building contract between travelodge services limited and try construction limited in relation to the development. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental development debenture (relating to a development debenture dated 4 february 2003) | Erstellt am 27. Mai 2003 Geliefert am 12. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor or any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in the development agreement and the building contract. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Feb. 2003 Geliefert am 18. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money or liabilities whatsoever due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Feb. 2003 Geliefert am 12. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0