TLLC CMPROPCO1 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TLLC CMPROPCO1 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04588947 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TLLC CMPROPCO1 LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TLLC CMPROPCO1 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Kpmg Llp Arlington Business Park Theale RG7 4SD Reading Berkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TLLC CMPROPCO1 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
VIOLETDEW LIMITED | 13. Nov. 2002 | 13. Nov. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TLLC CMPROPCO1 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2013 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TLLC CMPROPCO1 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 27 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Dez. 2015 | 49 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ zum Kpmg Llp Arlington Business Park Theale Reading Berkshire RG7 4SD am 24. Dez. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 7 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Mark Leslau am 17. Sept. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 20 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Miss Sandra Louise Gumm am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Miss Sandra Louise Gumm am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Mark Leslau am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Miss Sandra Louise Gumm am 01. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TLLC CMPROPCO1 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUMM, Sandra Louise | Sekretär | Arlington Business Park Theale RG7 4SD Reading Kpmg Llp Berkshire | Australian | Chartered Accountant | 57113450003 | |||||
GUMM, Sandra Louise | Geschäftsführer | Arlington Business Park Theale RG7 4SD Reading Kpmg Llp Berkshire | England | Australian | Chartered Accountant | 57113450003 | ||||
LESLAU, Nicholas Mark | Geschäftsführer | Arlington Business Park Theale RG7 4SD Reading Kpmg Llp Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 6815470021 | ||||
HICKS, Christopher Michael | Sekretär | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | Accountant | 53932930001 | |||||
JACKSON, Kevin David | Sekretär | Field House 147 Main Street Sutton Bonington LE12 5PE Loughborough | British | Property Director | 141586330001 | |||||
MORTIMORE, Jon William | Sekretär | Southdown Lodge 43 The Downs Wimbledon SW20 8HE London | British | Company Director | 93906210001 | |||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
TRAVELREST SERVICES LIMITED | Sekretär | Parklands Court 24 Parklands Birmingham Great Park Rubery B45 9PZ Birmingham West Midlands | 42204690005 | |||||||
HEARN, Grant David | Geschäftsführer | Bishops Platt Norlands Lane TW20 8SS Thorpe Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 88628480001 | ||||
HICKS, Christopher Michael | Geschäftsführer | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | Accountant | 53932930001 | |||||
JACKSON, Kevin David | Geschäftsführer | Field House 147 Main Street Sutton Bonington LE12 5PE Loughborough | England | British | Property Director | 141586330001 | ||||
LAYTON, Matthew Robert | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
MORTIMORE, Jon William | Geschäftsführer | Southdown Lodge 43 The Downs Wimbledon SW20 8HE London | United Kingdom | British | Company Director | 93906210001 | ||||
RICHARDS, Martin Edgar | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
TURL, Simon Charles | Geschäftsführer | Arden House Eastwell Road LE14 4SS Scalford Leicestershire | British | Director | 80261230001 | |||||
TURNER, Harry | Geschäftsführer | Shepherds Cottage The Vale Golf & Country Club Bishampton Fields WR10 2LZ Bishampton Near Pershore Worcestershire | England | British | Chief Operating Officer | 166789700001 |
Hat TLLC CMPROPCO1 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Confirmatory security agreement | Erstellt am 28. Jan. 2010 Geliefert am 04. Feb. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security deed | Erstellt am 19. Okt. 2004 Geliefert am 27. Okt. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All f/h and l/h property, all buildings erections fixtures fittings (including trade fixtures and fittings) fixed plant and machinery, investments, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, contracts, intercompany loans, goodwill & uncalled capital floating charge all assets not charged or assigned under the deed, all assets located in scotland. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security which was presented for registration in scotland on 14 february 2003 and | Erstellt am 04. Feb. 2003 Geliefert am 27. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money or liabilities due or to become due from the company or by any other obligor to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The subjects at 9 bridge street and 165 union street,aberdeen; t/no abn 18435. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security which was presented for registration in scotland on 14 february 2003 and | Erstellt am 04. Feb. 2003 Geliefert am 27. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money or liabilities due or to become due from the company or by any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The subjects at 9 bridge street and 165 union street,aberdeen; t/no abn 18435. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Feb. 2003 Geliefert am 18. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money or liabilities whatsoever due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Including lands at kendrick st,warrington,CH436481;1 midpoint,dick lane,pudsey,bradford,WYK678625;riverside,nottingham,NT328755. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Feb. 2003 Geliefert am 12. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat TLLC CMPROPCO1 LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0