TER 300 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TER 300 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04589136 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TER 300 LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich TER 300 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Victoria Works Thrumpton Lane DN22 6HH Retford Nottinghamshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TER 300 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ICON POLYMER HOLDINGS LIMITED | 15. Jan. 2003 | 15. Jan. 2003 |
| WEAVEDEGREE LIMITED | 13. Nov. 2002 | 13. Nov. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TER 300 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TER 300 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed icon polymer holdings LIMITED\certificate issued on 23/02/12 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy Denzil Pryce am 24. Aug. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy Denzil Pryce am 11. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2006 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TER 300 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINN, Shaun Raymond | Sekretär | 11 Nottingham Road Lowdham NG14 7AL Nottingham | British | 112482850001 | ||||||
| FINN, Shaun Raymond | Geschäftsführer | 11 Nottingham Road Lowdham NG14 7AL Nottingham | England | British | 112482850001 | |||||
| PRYCE, Timothy Denzil | Geschäftsführer | Thrumpton Lane DN22 6HH Retford Victoria Works Nottinghamshire | United Kingdom | British | 139882140005 | |||||
| HARRIS, Mark Smeeth | Sekretär | 21 Oakdene Sunningdale SL5 0BU Ascot Berkshire | British | 104260670001 | ||||||
| JOHNSON, Joanne Elizabeth | Sekretär | 47 Rockleigh Road SO16 7AQ Southampton Hampshire | British | 86411760001 | ||||||
| SUNTER, Amanda Jane | Sekretär | 664 Rayleigh Road Hutton CM13 1SJ Brentwood Essex | British | 44240520002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BAILEY, Roger Piers Marden | Geschäftsführer | Cheriton Pikes Hill Avenue SO43 7AX Lyndhurst Hampshire | British | 104169400001 | ||||||
| CALLAN, Maurice Simon | Geschäftsführer | Ayres Cottage 71 Bicester Road Long Crendon HP18 9EE Aylesbury Buckinghamshire | British | 72172980001 | ||||||
| GOGERTY, Richard Howard | Geschäftsführer | Marriner Crescent LN2 1BB Lincoln 2 Lincolnshire | England | British | 83926860003 | |||||
| HARRIS, Mark Smeeth | Geschäftsführer | 21 Oakdene Sunningdale SL5 0BU Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 104260670001 | |||||
| JOHNSON, Joanne Elizabeth | Geschäftsführer | 47 Rockleigh Road SO16 7AQ Southampton Hampshire | England | British | 86411760001 | |||||
| MCGOWAN, John Peter | Geschäftsführer | Lantern House Abbotswood WR11 4NS Evesham Worcestershire | British | 62509010002 | ||||||
| SUNTER, Amanda Jane | Geschäftsführer | 664 Rayleigh Road Hutton CM13 1SJ Brentwood Essex | British | 44240520002 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat TER 300 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 24. Dez. 2004 Geliefert am 12. Jan. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Dez. 2004 Geliefert am 07. Jan. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Omnibus letter of set-off | Erstellt am 12. Dez. 2002 Geliefert am 19. Dez. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of an account,as defined,whether in sterling or any other currency and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum and "credit balances"; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Dez. 2002 Geliefert am 19. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Dez. 2002 Geliefert am 19. Dez. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0