TLLC BRIDGECO9 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTLLC BRIDGECO9 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04589583
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TLLC BRIDGECO9 LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich TLLC BRIDGECO9 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3AB
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TLLC BRIDGECO9 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BOXGRANGE LIMITED13. Nov. 200213. Nov. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TLLC BRIDGECO9 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für TLLC BRIDGECO9 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beschlüsse

    Resolutions
    18 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Satzung und/oder der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Re sect 175 12/03/2010
    RES13

    Änderung der Details des Direktors für Paul Victor Harvey am 03. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Guy Paul Cuthbert Parsons am 03. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Grant David Hearn am 03. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Jon William Mortimore am 03. Feb. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Jon William Mortimore am 03. Feb. 2010

    1 SeitenCH03

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Dez. 2009

    Kapitalaufstellung am 03. Dez. 2009

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    legacy

    2 Seiten403a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    3 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    8 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    15 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    10 Seiten395

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von TLLC BRIDGECO9 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Sekretär
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    British93906210001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HARVEY, Paul Victor
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritish116809270002
    HEARN, Grant David
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    EnglandBritish88628480002
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritish93906210001
    PARSONS, Guy Paul Cuthbert
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritish102187770002
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Sekretär
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Sekretär
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    British141586330001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TRAVELREST SERVICES LIMITED
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    42204690005
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Geschäftsführer
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    EnglandBritish141586330001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    TURL, Simon Charles
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    British80261230001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish166789700001

    Hat TLLC BRIDGECO9 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 09. Nov. 2006
    Geliefert am 18. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juni 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Feb. 2003
    Geliefert am 18. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money or liabilities whatsoever due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including land at cambridge west and sutton scotney,near winchester; CB58531,CB233100 and HP522466. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC,London as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Feb. 2003
    Geliefert am 12. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties("Security Agent")
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0