TLLC BRIDGECO10 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TLLC BRIDGECO10 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04589588 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TLLC BRIDGECO10 LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TLLC BRIDGECO10 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Kpmg Llp 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TLLC BRIDGECO10 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BOXCROFT LIMITED | 13. Nov. 2002 | 13. Nov. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TLLC BRIDGECO10 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2013 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TLLC BRIDGECO10 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 15 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Apr. 2016 | 15 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ zum Kpmg Llp 15 Canada Square London E14 5GL am 04. Nov. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 6 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 13 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 14 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Mark Leslau am 17. Sept. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy James Evans am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Mark Leslau am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Miss Sandra Louise Gumm am 01. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TLLC BRIDGECO10 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUMM, Sandra Louise | Sekretär | Canada Square E14 5GL London Kpmg Llp 15 | Australian | 57113450003 | ||||||
| EVANS, Timothy James | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London Kpmg Llp 15 | United Kingdom | British | 104934670002 | |||||
| GUMM, Sandra Louise | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London Kpmg Llp 15 | England | Australian | 57113450003 | |||||
| LESLAU, Nicholas Mark | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London Kpmg Llp 15 | United Kingdom | British | 6815470021 | |||||
| HICKS, Christopher Michael | Sekretär | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | 53932930001 | ||||||
| JACKSON, Kevin David | Sekretär | Field House 147 Main Street Sutton Bonington LE12 5PE Loughborough | British | 141586330001 | ||||||
| MORTIMORE, Jon William | Sekretär | Southdown Lodge 43 The Downs Wimbledon SW20 8HE London | British | 93906210001 | ||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| TRAVELREST SERVICES LIMITED | Sekretär | Parklands Court 24 Parklands Birmingham Great Park Rubery B45 9PZ Birmingham West Midlands | 42204690005 | |||||||
| HARVEY, Paul Victor | Geschäftsführer | 4 Hallam Mews W1W 6AP London | United Kingdom | British | 116809270002 | |||||
| HEARN, Grant David | Geschäftsführer | Bishops Platt Norlands Lane TW20 8SS Thorpe Surrey | United Kingdom | British | 88628480001 | |||||
| HICKS, Christopher Michael | Geschäftsführer | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | 53932930001 | ||||||
| JACKSON, Kevin David | Geschäftsführer | Field House 147 Main Street Sutton Bonington LE12 5PE Loughborough | England | British | 141586330001 | |||||
| LAYTON, Matthew Robert | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
| MORTIMORE, Jon William | Geschäftsführer | Southdown Lodge 43 The Downs Wimbledon SW20 8HE London | United Kingdom | British | 93906210001 | |||||
| PARSONS, Guy Paul Cuthbert | Geschäftsführer | Mornington House 40 Parkside SW19 5BN London | United Kingdom | British | 102187770002 | |||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
| STOREY, Mark | Geschäftsführer | 11 Ripon Street HP20 2JP Aylesbury Buckinghamshire | British | 121960950001 | ||||||
| TURL, Simon Charles | Geschäftsführer | Arden House Eastwell Road LE14 4SS Scalford Leicestershire | British | 80261230001 | ||||||
| TURNER, Harry | Geschäftsführer | Shepherds Cottage The Vale Golf & Country Club Bishampton Fields WR10 2LZ Bishampton Near Pershore Worcestershire | England | British | 166789700001 |
Hat TLLC BRIDGECO10 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Assignation of rents | Erstellt am 01. Juni 2007 Geliefert am 12. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The assignor's entire right,title and interest in the rental income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 14/06/2007 and | Erstellt am 22. Mai 2007 Geliefert am 21. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H service area A1 old craighall musselburgh t/no MID43086. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 22. Mai 2007 Geliefert am 11. Juni 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all property and assets including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of rents dated 1 december 2006 and intimation dated | Erstellt am 07. Dez. 2006 Geliefert am 20. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The rental income payable under the occupational leases. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental charge | Erstellt am 05. Dez. 2006 Geliefert am 13. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All that property situated at harrow place london l/h t/n NGL636402 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 5 december 2006 | Erstellt am 01. Dez. 2006 Geliefert am 13. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H subjects k/a and forming the travelodge musselburgh service area, A1, old craighall, musselburgh t/no MID43086. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Nov. 2006 Geliefert am 18. Nov. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental leverage debenture relating to the original debenture | Erstellt am 06. Okt. 2003 Geliefert am 18. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any chargor or other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property being :-leasehold land being land on the east side of derby road, alfreton, derbyshire t/n DY184164. 2) leasehold land consisting of the travelodge and little chef situated at the A1 northbound, new fox, south witham. 3) l/h land at shrewsbury road, mile end services, owestry, t/n SL47567. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental term debenture relating to the original debenture | Erstellt am 06. Okt. 2003 Geliefert am 18. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any chargor or other obligor to any finance party. Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property being the l/h land being land on the east side of derby road, alfreton, derbyshire t/n DY184164. L/h land the travelodge & little chef at A1 northbound, new fox, south witham, colsterworth. L/h land at shrewsbury road, mile end services, oswestry t/n SL47567. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 10/10/03 and | Erstellt am 01. Okt. 2003 Geliefert am 21. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The tenant's interest under the lease dated 4TH february and 4TH march 1991 of musselburgh service area, newcraighall, edinburgh t/n MID43086. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 10/10/03 and | Erstellt am 01. Okt. 2003 Geliefert am 21. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The tenant's interest under the lease dated 4TH february and 4TH march 1991 of musselburgh service area, newcraighall, edinburgh t/n MID43086. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Feb. 2003 Geliefert am 18. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money or liabilities whatsoever due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Including new fox north,south witham,lincolnshire; DY184164;derby rd,alfreton swanwick;SL47567 and mile end services,oswestry. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. Feb. 2003 Geliefert am 12. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TLLC BRIDGECO10 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0