TLLC BRIDGECO10 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTLLC BRIDGECO10 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04589588
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kpmg Llp 15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BOXCROFT LIMITED13. Nov. 200213. Nov. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2013

    Welche sind die letzten Einreichungen für TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    15 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Apr. 2016

    15 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ zum Kpmg Llp 15 Canada Square London E14 5GL am 04. Nov. 2015

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 27. Apr. 2015

    LRESEX

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 03. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Nov. 2013

    Kapitalaufstellung am 05. Nov. 2013

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Mark Leslau am 17. Sept. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy James Evans am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas Mark Leslau am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Miss Sandra Louise Gumm am 01. Okt. 2009

    1 SeitenCH03

    Wer sind die Geschäftsführer von TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Australian57113450003
    EVANS, Timothy James
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    United KingdomBritish104934670002
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    EnglandAustralian57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    United KingdomBritish6815470021
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Sekretär
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Sekretär
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    British141586330001
    MORTIMORE, Jon William
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    Sekretär
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    British93906210001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TRAVELREST SERVICES LIMITED
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    42204690005
    HARVEY, Paul Victor
    4 Hallam Mews
    W1W 6AP London
    Geschäftsführer
    4 Hallam Mews
    W1W 6AP London
    United KingdomBritish116809270002
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Geschäftsführer
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritish88628480001
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Geschäftsführer
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    EnglandBritish141586330001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MORTIMORE, Jon William
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    Geschäftsführer
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    United KingdomBritish93906210001
    PARSONS, Guy Paul Cuthbert
    Mornington House
    40 Parkside
    SW19 5BN London
    Geschäftsführer
    Mornington House
    40 Parkside
    SW19 5BN London
    United KingdomBritish102187770002
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    STOREY, Mark
    11 Ripon Street
    HP20 2JP Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    11 Ripon Street
    HP20 2JP Aylesbury
    Buckinghamshire
    British121960950001
    TURL, Simon Charles
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    British80261230001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish166789700001

    Hat TLLC BRIDGECO10 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Assignation of rents
    Erstellt am 01. Juni 2007
    Geliefert am 12. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assignor's entire right,title and interest in the rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 14/06/2007 and
    Erstellt am 22. Mai 2007
    Geliefert am 21. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H service area A1 old craighall musselburgh t/no MID43086.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. März 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security agreement
    Erstellt am 22. Mai 2007
    Geliefert am 11. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all property and assets including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Agent)
    Transaktionen
    • 11. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Assignation of rents dated 1 december 2006 and intimation dated
    Erstellt am 07. Dez. 2006
    Geliefert am 20. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The rental income payable under the occupational leases. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC, for Itself as a Secured Party and as Security Trustee for Theother Secured Parties
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 05. Dez. 2006
    Geliefert am 13. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that property situated at harrow place london l/h t/n NGL636402 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties(The "Security Agent")
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 5 december 2006
    Erstellt am 01. Dez. 2006
    Geliefert am 13. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H subjects k/a and forming the travelodge musselburgh service area, A1, old craighall, musselburgh t/no MID43086.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC for Itself as a Secured Party and as Security Trustee for Theother Secured Parties
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Nov. 2006
    Geliefert am 18. Nov. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transaktionen
    • 18. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental leverage debenture relating to the original debenture
    Erstellt am 06. Okt. 2003
    Geliefert am 18. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by any chargor or other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property being :-leasehold land being land on the east side of derby road, alfreton, derbyshire t/n DY184164. 2) leasehold land consisting of the travelodge and little chef situated at the A1 northbound, new fox, south witham. 3) l/h land at shrewsbury road, mile end services, owestry, t/n SL47567.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotand PLC as Security for Itself and the Other Secured Parties(The Security Agent)
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental term debenture relating to the original debenture
    Erstellt am 06. Okt. 2003
    Geliefert am 18. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by any chargor or other obligor to any finance party. Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property being the l/h land being land on the east side of derby road, alfreton, derbyshire t/n DY184164. L/h land the travelodge & little chef at A1 northbound, new fox, south witham, colsterworth. L/h land at shrewsbury road, mile end services, oswestry t/n SL47567.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security for Itself and the Other Secured Parties(The Security Agent)
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10/10/03 and
    Erstellt am 01. Okt. 2003
    Geliefert am 21. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenant's interest under the lease dated 4TH february and 4TH march 1991 of musselburgh service area, newcraighall, edinburgh t/n MID43086.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10/10/03 and
    Erstellt am 01. Okt. 2003
    Geliefert am 21. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The tenant's interest under the lease dated 4TH february and 4TH march 1991 of musselburgh service area, newcraighall, edinburgh t/n MID43086.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Feb. 2003
    Geliefert am 18. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money or liabilities whatsoever due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Including new fox north,south witham,lincolnshire; DY184164;derby rd,alfreton swanwick;SL47567 and mile end services,oswestry. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC,London as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 04. Feb. 2003
    Geliefert am 12. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties("Security Agent")
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Sept. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat TLLC BRIDGECO10 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    27. Apr. 2015Beginn der Liquidation
    06. Dez. 2016Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Neil David Gostelow
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0