SIGNPOST SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SIGNPOST SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04594308 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SIGNPOST SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich SIGNPOST SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 5 Clarendon Drive, The Parkway DY4 0QA Tipton West Midlands |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SIGNPOST SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BROOMCO (3076) LIMITED | 19. Nov. 2002 | 19. Nov. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SIGNPOST SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SIGNPOST SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 25. Mai 2016
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rhoderic Gavin Iain Adams als Geschäftsführer am 31. Jan. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Ernennung von Jeremy Peter Cowling als Direktor am 17. Aug. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Nicholas als Geschäftsführer am 29. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dermot Gerald William Murphy als Geschäftsführer am 31. Juli 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 27 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Sampson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 10 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Andrew Patrick Corrie Sampson am 14. Aug. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Alan Nicholas am 14. Aug. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Rhoderic Gavin Iain Adams am 14. Aug. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SIGNPOST SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOVER, Neale Keith | Sekretär | c/o Signpost Solutions Holdings Ltd Clarendon Drive The Parkway DY4 0QA Tipton Unit 5 West Midlands England | British | Financial Direc | 93014660002 | |||||
COWLING, Jeremy Peter | Geschäftsführer | Clarendon Drive, The Parkway DY4 0QA Tipton Unit 5 West Midlands | England | British | Company Director | 200404820001 | ||||
GLOVER, Neale Keith | Geschäftsführer | c/o Signpost Solutions Holdings Ltd Clarendon Drive The Parkway DY4 0QA Tipton Unit 5 West Midlands England | England | British | Financial Direc | 93014660002 | ||||
NICKLIN, Christopher Thomas | Geschäftsführer | c/o Signpost Solutions Holdings Ltd Clarendon Drive The Parkway DY4 0QA Tipton Unit 5 West Midlands England | England | British | Director | 73636420002 | ||||
MOORE, Colin Peter | Sekretär | 21 Ward Grove WV4 6PH Wolverhampton West Midlands | British | Director | 68327710001 | |||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
ADAMS, Rhoderic Gavin Iain | Geschäftsführer | c/o Apt Controls Ltd Chantry Place Headstone Lane HA3 6NY Harrow The Power House Middlesex England | England | British | Director | 17019110002 | ||||
MOORE, Colin Peter | Geschäftsführer | Owlswick Main Road, Norton-In-Hales TF9 4AT Market Drayton Shropshire | United Kingdom | British | Director | 68327710002 | ||||
MURPHY, Dermot Gerald William | Geschäftsführer | c/o Apt Controls Ltd Chantry Place Headstone Lane HA3 6NY Harrow The Power House Middlesex England | England | Irish | Director | 19471270004 | ||||
NICHOLAS, Alan | Geschäftsführer | c/o Signpost Solutions Holdings Ltd Clarendon Drive The Parkway DY4 0QA Tipton Unit 5 West Midlands England | England | British | Sales & Marketing Director | 88361110004 | ||||
PATERSON, Hamish | Geschäftsführer | Quebec 70 Claverham Road Yatton BS49 4LD Bristol | England | British | Company Director | 88361190002 | ||||
SAMPSON, Andrew Patrick Corrie | Geschäftsführer | c/o Apt Controls Ltd Chantry Place Headstone Lane HA3 6NY Harrow The Power House Middlesex England | England | British | Director | 14937620001 | ||||
SANDS, Peter Edward | Geschäftsführer | 8 Amberley Way Wickwar GL12 8LP Wotton-Under-Edge Gloucestershire | United Kingdom | British | Director | 209175000001 | ||||
DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 | |||||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SIGNPOST SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apt Controls Limited | 06. Apr. 2016 | Chantry Place Headstone Lane HA3 6NY Harrow The Power House Middlesex England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat SIGNPOST SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 01. Apr. 2008 Geliefert am 11. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment of life policy | Erstellt am 07. März 2003 Geliefert am 13. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Policy number 30C31M59 held by st james's place in the name of hamish paterson and all money that may become payable under the policy subject to reassignment on redemption. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment of life policy | Erstellt am 07. März 2003 Geliefert am 13. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Policy number 30C29N93 held by st james's place in the name of alan nicholas and all money that may become payable under the policy subject to reassignment or redemption. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment of life policy | Erstellt am 07. März 2003 Geliefert am 13. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Policy number 30C07C33 held by st james's place in the name of peter moore and all money that may become payable under the policy subject to reassignment or redemption. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. März 2003 Geliefert am 13. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0