ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04594316 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?
- Pflegeheime (86102) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| EASTWOOD CARE PARTNERSHIPS (NO.1.) LIMITED | 02. Apr. 2003 | 02. Apr. 2003 |
| BROOMCO (3065) LIMITED | 19. Nov. 2002 | 19. Nov. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 6 Seiten | 1.4 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 17. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs | 4 Seiten | 1.1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 26 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kamma Foulkes als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Farmer als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158304640001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Sekretär | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146620002 | |||||||
| BOLOT, Timothy James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BUCHAN, William James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Geschäftsführer | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| FARMER, Nicholas John | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 124228290001 | |||||
| FOULKES, Kamma | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| LOCK, Jason David | Geschäftsführer | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 110640170001 | |||||
| MURPHY, John | Geschäftsführer | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | 26177180004 | |||||
| MURRAY, Andrew John | Geschäftsführer | 10 Rosgill Drive Middleton M24 4SQ Manchester Lancashire | British | 110957990001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Geschäftsführer | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SCOTT, Philip Henry | Geschäftsführer | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | 174231320001 | |||||
| SIZER, Graham Kevin | Geschäftsführer | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | 77274540003 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Durham Road Low Fell NE9 5AL Gateshead 377 England England | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146610001 | |||||||
| DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 54146620002 |
Hat ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Erstellt am 14. Nov. 2003 Geliefert am 29. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 14. Nov. 2003 Geliefert am 04. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H premises situate at arkwright centre, irchester road, knuston, spinney, northampton, northants, NN9 7EY. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 11. Nov. 2003 Geliefert am 25. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Abbeydale court nursing home, bistern avenue, walthamstow, london. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 11. Nov. 2003 Geliefert am 21. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit being the sum of £102,600 all interest the deposit account being an interest bearing account specifically designated "abeydale court nursing home deposit account" and the deposit balance being the sum from time to time standing to the credit of the deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 04. Nov. 2003 Geliefert am 14. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 04. Nov. 2003 Geliefert am 14. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 04. Nov. 2003 Geliefert am 13. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a colchester court nursing home, 120 colchester road, leicester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 04. Nov. 2003 Geliefert am 13. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Orchard court nursing home, 3A orchard gardens, thurmaston, leicester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 30. Okt. 2003 Geliefert am 14. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage all right title and other interests of the company in l/h premises situate at holly lodge residential home 1 bocking hill haywood lane stocksbridge sheffield south yorkshire together with all buildings structures fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 30. Okt. 2003 Geliefert am 14. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 30. Okt. 2003 Geliefert am 14. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 30. Okt. 2003 Geliefert am 13. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a rufford court nursing home, 3/5 the cliff, cinderhill road, nottingham. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 28. Okt. 2003 Geliefert am 14. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 28. Okt. 2003 Geliefert am 14. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 28. Okt. 2003 Geliefert am 14. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 28. Okt. 2003 Geliefert am 12. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H premises at holly house nursing home beechley harthill road allerton liverpool L18 3HU. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 28. Okt. 2003 Geliefert am 12. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben In the l/h premises at holly house nursing home (barberry)12 ullet road aigburth liverpool L8 3SR. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 28. Okt. 2003 Geliefert am 12. Nov. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H premises k/a tarry hill specialist residential home, 3,5 and 7 cale road, new mills, high peak, derbyshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0