ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED

ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04594316
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    • Pflegeheime (86102) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EASTWOOD CARE PARTNERSHIPS (NO.1.) LIMITED02. Apr. 200302. Apr. 2003
    BROOMCO (3065) LIMITED19. Nov. 200219. Nov. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012

    1 SeitenTM02

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    6 Seiten1.4

    Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 17. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    4 Seiten1.1

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Dez. 2011

    Kapitalaufstellung am 06. Dez. 2011

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    26 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Enter agreements 14/05/2010
    RES13

    Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009

    25 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David Smith als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Kamma Foulkes als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Farmer als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304640001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Sekretär
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    FARMER, Nicholas John
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish124228290001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Geschäftsführer
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Geschäftsführer
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    MURRAY, Andrew John
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    British110957990001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Geschäftsführer
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Geschäftsführer
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Geschäftsführer
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritish147997950001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146610001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002

    Hat ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rent deposit deed
    Erstellt am 14. Nov. 2003
    Geliefert am 29. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 14. Nov. 2003
    Geliefert am 04. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises situate at arkwright centre, irchester road, knuston, spinney, northampton, northants, NN9 7EY. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 11. Nov. 2003
    Geliefert am 25. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Abbeydale court nursing home, bistern avenue, walthamstow, london. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 10 Limited
    Transaktionen
    • 25. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 11. Nov. 2003
    Geliefert am 21. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit being the sum of £102,600 all interest the deposit account being an interest bearing account specifically designated "abeydale court nursing home deposit account" and the deposit balance being the sum from time to time standing to the credit of the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 04. Nov. 2003
    Geliefert am 14. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 04. Nov. 2003
    Geliefert am 14. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 04. Nov. 2003
    Geliefert am 13. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a colchester court nursing home, 120 colchester road, leicester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 10 Limited
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 04. Nov. 2003
    Geliefert am 13. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Orchard court nursing home, 3A orchard gardens, thurmaston, leicester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 10 Limited
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. Okt. 2003
    Geliefert am 14. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage all right title and other interests of the company in l/h premises situate at holly lodge residential home 1 bocking hill haywood lane stocksbridge sheffield south yorkshire together with all buildings structures fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 30. Okt. 2003
    Geliefert am 14. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 30. Okt. 2003
    Geliefert am 14. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Apr. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. Okt. 2003
    Geliefert am 13. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a rufford court nursing home, 3/5 the cliff, cinderhill road, nottingham. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 10 Limited
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Okt. 2003
    Geliefert am 14. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Okt. 2003
    Geliefert am 14. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Okt. 2003
    Geliefert am 14. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Okt. 2003
    Geliefert am 12. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises at holly house nursing home beechley harthill road allerton liverpool L18 3HU. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Okt. 2003
    Geliefert am 12. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    In the l/h premises at holly house nursing home (barberry)12 ullet road aigburth liverpool L8 3SR. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Okt. 2003
    Geliefert am 12. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises k/a tarry hill specialist residential home, 3,5 and 7 cale road, new mills, high peak, derbyshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transaktionen
    • 12. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)

    Hat ACTIVE CARE PARTNERSHIPS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Juni 2012Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    20. Aug. 2012Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praktiker
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0