FAWKES PHOENIX LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FAWKES PHOENIX LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04597339 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FAWKES PHOENIX LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich FAWKES PHOENIX LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | King Loose & Co. St. John's House 5 South Parade OX2 7JL OX2 7JL Summertown Oxford United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FAWKES PHOENIX LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ALBURN (SOUTH EAST) LIMITED | 21. Nov. 2002 | 21. Nov. 2002 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FAWKES PHOENIX LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FAWKES PHOENIX LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 30. Juni 2021 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 30. Juni 2020 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geprüfte Jahresabschluss, gekürzt, bis 30. Juni 2019 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Markboard Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC03 | ||||||||||
Cessation of Anne Marie Smyth as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Bryan William Lawlor am 01. Jan. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Notification of Anne Marie Smyth as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O King Loose St Johns House 5 South Parade Sommertown Oxford OX2 7JL zum PO Box OX2 7JL King Loose & Co. St. John's House 5 South Parade Summertown Oxford OX2 7JL am 04. Apr. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. März 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Alannah Smyth als Direktor am 21. Feb. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FAWKES PHOENIX LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMYTH, Alannah | Sekretär | Portobello Road Dublin 8 29 Ireland | 154701650001 | |||||||
| KINNAIRD, Nigel John | Geschäftsführer | 14 Magheraconluce Lane BT26 6PT Hillsborough County Down | Northern Ireland | British | 83042830001 | |||||
| LAWLOR, Bryan William | Geschäftsführer | Kenilworth Square Dublin 6 60 Ireland | Ireland | Irish | 154652750015 | |||||
| SMYTH, Alannah | Geschäftsführer | Portobello Road Dublin 8 29 Ireland | Ireland | Irish | 225157700001 | |||||
| SMYTH, Noel Martin | Geschäftsführer | 25 Tooting Bec Road SW17 8BY London Flat 7 England | Ireland | Irish | 91238420002 | |||||
| LAWLOR, Bryan William | Sekretär | Coolamber Court Knocklyon Road 21 Dublin 16 Republic Of Ireland | Irish | 102461750012 | ||||||
| MORAN, John | Sekretär | 10 Fitzwilliam Square Dublin Dublin 2 Ireland | Irish | 81598910001 | ||||||
| OLSWANG COSEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Third Floor 90 Long Acre WC2E 9TT London | 900022270001 | |||||||
| LAWLOR, Bryan William | Geschäftsführer | Rodini Waterford Road County Kilkenny Republic Of Ireland | Irish | 102461750001 | ||||||
| MCKENNA, John | Geschäftsführer | 34 Brighton Square Rathgar IRISH Dublin 6 Republic Of Ireland | Ireland | Irish | 116525480001 | |||||
| MORAN, John | Geschäftsführer | 10 Fitzwilliam Square Dublin Dublin 2 Ireland | Irish | 81598910001 | ||||||
| OLSWANG DIRECTORS 1 LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Third Floor 90 Long Acre WC2E 9TT London | 900022260001 | |||||||
| OLSWANG DIRECTORS 2 LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Third Floor 90 Long Acre WC2E 9TT London | 900022250001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FAWKES PHOENIX LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms. Anne Marie Smyth | 06. Apr. 2016 | Elm House Leopardstown Office Park Sandyford Second Floor Dublin 18 Ireland | Ja | ||||
Nationalität: Irish Staatsangehörigkeit: Ireland | |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
| Markboard Limited | 06. Apr. 2016 | St. John's House 5 South Parade OX2 7JL Summertown, Oxford King Loose & Co. England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat FAWKES PHOENIX LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge on account | Erstellt am 02. Sept. 2011 Geliefert am 02. Sept. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of charge and assignment the security account, the deposit and the debt. By charge on account, by way of floating charge the security account, the deposit and the debt see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Okt. 2007 Geliefert am 06. Okt. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 2006 Geliefert am 04. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property known as 21-22 grosvenor street london and 21-22 brooks mews london t/n NGL806938,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| New guarantor debenture | Erstellt am 04. Apr. 2003 Geliefert am 24. Apr. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or the borrower to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge | Erstellt am 28. Jan. 2003 Geliefert am 01. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and alburn (commercial) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H land k/a 1 old foge ind estate redditch part HW99625 and part HW188624, l/h land k/a site 3C crompton way segensworth part HP270506 and l/h land k/a units 1-3 moreton ind. Est. Swanley sevenoaks part K469003 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0