WHITEHEATHER CARE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | WHITEHEATHER CARE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04600377 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WHITEHEATHER CARE LIMITED?
- Betreuungseinrichtungen für ältere und behinderte Menschen (87300) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich WHITEHEATHER CARE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Bradbury House 830 The Crescent Colchester CO4 9YQ Business Park Colchester Essex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WHITEHEATHER CARE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WHITEHEATHER CARE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 046003770007 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 046003770008 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 046003770009 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Consensus Support Services Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Paul Anthony Keith Jeffery as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Nov. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 2 | 2 Seiten | MR05 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WHITEHEATHER CARE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHOFIELD, Nigel Bennett | Sekretär | Bradbury House 830 The Crescent Colchester CO4 9YQ Business Park Colchester Essex | British | 52338530002 | ||||||
| HILL, Peter Martin | Geschäftsführer | Bradbury House 830 The Crescent Colchester CO4 9YQ Business Park Colchester Essex | England | British | 130983750001 | |||||
| JEFFERY, Paul Anthony Keith | Geschäftsführer | Bradbury House 830 The Crescent Colchester CO4 9YQ Business Park Colchester Essex | United Kingdom | British | 65609290003 | |||||
| SCHOFIELD, Nigel Bennett | Geschäftsführer | Bradbury House 830 The Crescent Colchester CO4 9YQ Business Park Colchester Essex | United Kingdom | British | 148139420001 | |||||
| HARDEN, David Raymond | Sekretär | Colts Lower Farm Lane CO7 0SU Brightlingsea Essex | British | 73311040002 | ||||||
| TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
| CORMACK, Derek George | Geschäftsführer | Pillars Grantley Avenue, Wonersh GU5 0QN Guildford Surrey | England | Irish | 67400530015 | |||||
| GRIFFIN, Craig | Geschäftsführer | Halebourne House Halebourne Lane GU24 8SL Chobham Surrey | United Kingdom | British | 154122490001 | |||||
| GUNASENE, Gamika Rasal | Geschäftsführer | 2 The Jays Highwoods CO4 9TW Colchester Essex | United Kingdom | British | 71473790001 | |||||
| GUNASENE, Vasudha Lavangi | Geschäftsführer | 2 The Jays Highwoods CO4 9TW Colchester Essex | United Kingdom | British | 71473730002 | |||||
| HARDEN, David Raymond | Geschäftsführer | Colts Lower Farm Lane CO7 0SU Brightlingsea Essex | United Kingdom | British | 73311040002 | |||||
| JEFFERY, Helena | Geschäftsführer | Orchards Frating Road CO7 7JW Great Bromley Essex | British | 71215830002 | ||||||
| WHITE, Ian James | Geschäftsführer | Bradbury House 830 The Crescent Colchester CO4 9YQ Business Park Colchester Essex | England | British | 133383410003 | |||||
| COMPANY DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WHITEHEATHER CARE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consensus Support Services Limited | 06. Apr. 2018 | 830 The Crescent Colchester Business Park CO4 9YQ Colchester Bradbury House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Paul Anthony Keith Jeffery | 06. Apr. 2016 | Bradbury House 830 The Crescent Colchester CO4 9YQ Business Park Colchester Essex | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat WHITEHEATHER CARE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 11. Sept. 2013 Geliefert am 19. Sept. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 11. Sept. 2013 Geliefert am 17. Sept. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 11. Sept. 2013 Geliefert am 16. Sept. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Juli 2010 Geliefert am 06. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Nov. 2007 Geliefert am 27. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Feb. 2007 Geliefert am 13. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession | Erstellt am 28. Feb. 2007 Geliefert am 13. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Feb. 2007 Geliefert am 13. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H white heather clacton road weeley t/no EX692963. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 15. Apr. 2003 Geliefert am 17. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a white heather clacton road weeley essex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0