ISIS NOMINEES (1) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ISIS NOMINEES (1) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04613340 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ISIS NOMINEES (1) LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich ISIS NOMINEES (1) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Lodge Odell MK43 7BB Bedford |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ISIS NOMINEES (1) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 05. Apr. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ISIS NOMINEES (1) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Apr. 2011 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Apr. 2010 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Tritax Management 1 Limited am 10. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Apr. 2009 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 05. Apr. 2008 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 05. Apr. 2007 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 05. Apr. 2006 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 05. Apr. 2005 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 05. Apr. 2004 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ISIS NOMINEES (1) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAW, Mark Glenn Bridgman | Sekretär | The Lodge High Street MK43 7PE Odell Bedfordshire | British | 146687830001 | ||||||||||
| TRITAX MANAGEMENT 1 LIMITED | Geschäftsführer | South Road RH16 4NG Haywards Heath Aberdeen House West Sussex England |
| 87393910002 | ||||||||||
| HSE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580006 | |||||||||||
| HSE DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London England | 73774730002 |
Hat ISIS NOMINEES (1) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 28. Feb. 2003 Geliefert am 17. März 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Including the leasehold premises known as unit 1,isis business park agecroft road,salford; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security over a deposit in a bank or building society | Erstellt am 28. Feb. 2003 Geliefert am 17. März 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The bank account held with the governor and company of the bank of scotland and numbered 6001265 with all monies held and all interest due and payable thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security over a deposit in a bank or building society | Erstellt am 28. Feb. 2003 Geliefert am 17. März 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The bank account held with the governor and company of the bank of scotland and numbered 06008272 with all monies held and all interest due and payable thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0