OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04621456 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Sept. 2018 | 7 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 29. Sept. 2017 | 7 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom The Place Ducie Street Manchester M1 2TP zum 15 Canada Square London E14 5GL am 20. Okt. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 19 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 19 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Dez. 2013 | 19 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 21 Tudor Street London EC4Y 0DJ verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 21 Tudor Street London EC4Y 0DJ geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 47 Seiten | 1.4 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brett Alan Lashley als Geschäftsführer am 04. Juni 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard James Spencer als Direktor am 04. Juni 2015 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Brett Alan Lashley als Direktor am 25. Feb. 2015 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Craig Allan Mellor als Sekretär am 25. Feb. 2015 | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gavin Robert Duncan als Geschäftsführer am 25. Feb. 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stuart Barrie Wall als Geschäftsführer am 25. Feb. 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Craig Allan Mellor als Geschäftsführer am 25. Feb. 2015 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Kpmg Llp 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB zum The Place Ducie Street Manchester M1 2TP am 06. März 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Mitteilung über das Ende der Verwaltung | 72 Seiten | 2.32B | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPENCER, Richard James | Geschäftsführer | 133 Fleet Street EC4A 2BB London Peterborough Court United Kingdom | United Kingdom | British | 190526870001 | |||||
| MELLOR, Craig Allan | Sekretär | 21 Queenston Road Didsbury M20 2NX Manchester | British | 60906780002 | ||||||
| TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
| DUNCAN, Gavin Robert | Geschäftsführer | Ducie Street M1 2TP Manchester The Place | England | British | 151512820001 | |||||
| LASHLEY, Brett Alan | Geschäftsführer | Ducie Street M1 2TP Manchester The Place | England | United States Of America | 196201790001 | |||||
| MARTIN, Graham Hunter | Geschäftsführer | Rosegarth 51 Adlington Road SK9 2BJ Wilmslow Cheshire | British | 87259480001 | ||||||
| MELLOR, Craig Allan | Geschäftsführer | Ducie Street M1 2TP Manchester The Place | England | British | 60906780002 | |||||
| WALL, Stuart Barrie | Geschäftsführer | Old Acres Well Bank Lane Over Peover WA16 8UN Knutsford Cheshire | United Kingdom | British | 95010340001 | |||||
| COMPANY DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
Hat OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Group debenture | Erstellt am 04. Apr. 2012 Geliefert am 19. Apr. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Pitfield street youth centre, pitfield street t/no EGL438260. Lyme view, 17 buxton road west, disley t/no CH519650. Land and buildings on the south east side of granby row t/no LA378335. (For further details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Assignment by way of security | Erstellt am 28. Apr. 2006 Geliefert am 09. Mai 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to those agreements being a building contract and a performance bond and any present or future collateral warranties. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Mai 2003 Geliefert am 27. Mai 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage the f/h property being land and buildings at 4 milton street sheffield t/no SYK457967 together with the l/h property t/no SYK435519 by way of assignment the gross rents licence fees and other monies receivable now or hereafter in respect of or arising out of any lease or any agreement for lease or otherwise, the benefit of all guarantees warranties and representations, the benefit of all and any agreements, by way of fixed charge all funds standing to the credit of the company, by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or for time to time. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Mai 2003 Geliefert am 19. Mai 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Mai 2003 Geliefert am 19. Mai 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The freehold property known as land and buildings at wellington street sheffield t/n SYK381544 together with the gross rents licence fees and other monies receivable now or hereafter in respect of or arising out of any lease of the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat OPAL SOUTH YORKSHIRE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 | Receiver/Manager bestellt |
| |||||||||||||||||||||||
| 3 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
| ||||||||||||||||||||||
| 4 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0