STATIONERY TRADING UK LIMITED

STATIONERY TRADING UK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSTATIONERY TRADING UK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04622023
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von STATIONERY TRADING UK LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich STATIONERY TRADING UK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von STATIONERY TRADING UK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ISA TRADING LIMITED16. Mai 200316. Mai 2003
    IBIS (810) LIMITED19. Dez. 200219. Dez. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STATIONERY TRADING UK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für STATIONERY TRADING UK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. März 2011

    6 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 16. Juli 2010

    10 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    10 Seiten2.34B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom K House Sheffield Business Park Europa Link Sheffield S9 1XU am 20. Apr. 2010

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 20. Jan. 2010

    10 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung eines Geschäftsführers

    2 SeitenTM01

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    27 Seiten2.17B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    37 SeitenMA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed isa trading LIMITED\certificate issued on 20/07/09
    3 SeitenCERTNM

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    22 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von STATIONERY TRADING UK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JOHNSTON, Wilfred Mark
    Dalebrook House
    Baslow Road
    S42 7DD Chesterfield
    Derbyshire
    Sekretär
    Dalebrook House
    Baslow Road
    S42 7DD Chesterfield
    Derbyshire
    British107055750001
    JOHNSTON, Wilfred Mark
    Dalebrook House
    Baslow Road
    S42 7DD Chesterfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Dalebrook House
    Baslow Road
    S42 7DD Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish107055750001
    MARTIN, Richard Joseph Fitzgerald
    Brook Farm
    Drinkstone Road, Beyton
    IP30 9AQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Brook Farm
    Drinkstone Road, Beyton
    IP30 9AQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritish185639660001
    GOLD, Daniel
    31 Hamilton Terrace
    NW8 9RG London
    Sekretär
    31 Hamilton Terrace
    NW8 9RG London
    British96573090001
    DECHERT SECRETARIES LIMITED
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    Sekretär
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    78403190002
    GOLD, Daniel
    31 Hamilton Terrace
    NW8 9RG London
    Geschäftsführer
    31 Hamilton Terrace
    NW8 9RG London
    British96573090001
    PALOS, Brett
    41 Queens Grove
    NW8 2HH London
    Geschäftsführer
    41 Queens Grove
    NW8 2HH London
    British89466920004
    DECHERT NOMINEES LIMITED
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    Geschäftsführer
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    73625410001

    Hat STATIONERY TRADING UK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of accession
    Erstellt am 06. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of accession
    Erstellt am 06. Juni 2007
    Geliefert am 26. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge any money standing to the credit of each designated account of that chargor and the debts by way of floating charge the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of accession
    Erstellt am 06. Juni 2007
    Geliefert am 23. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 20. Dez. 2006
    Geliefert am 10. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Office furniure freestanding bins speakers & it as described in chattel mortgage reference no KF964 sch 2.
    Berechtigte Personen
    • Key Finance Group Limited
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 20. Dez. 2006
    Geliefert am 10. Jan. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Office chairs desks filling cabinets conference table dell pc dell servers hp printers scanners & bins as described in chattel mortgage schedule reference no KF964 sch 1.
    Berechtigte Personen
    • Key Finance Group Limited
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Counterpart rent deposit deed
    Erstellt am 20. Apr. 2006
    Geliefert am 03. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £5,850.52 due or to become due from the company to
    Kurze Angaben
    The company hereby charges the rent deposit to the landlord.
    Berechtigte Personen
    • Durham Investments Six Limited
    Transaktionen
    • 03. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 03. Okt. 2005
    Geliefert am 14. Okt. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right,title,interest and benefit in and to the collection accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 14. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of insurance policy
    Erstellt am 28. Sept. 2005
    Geliefert am 30. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assignment of an amlin credit insurance policy no 200505-3-0024448/03-02 together with the right so far as may be necessary to demand performance or sue for and enforce the same in asignor's name.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 06. Mai 2004
    Geliefert am 19. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of insurance policy
    Erstellt am 23. Okt. 2003
    Geliefert am 31. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assignment of a royal & sun alliance insurance PLC insurance policy no: WO3OOO291. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and fixed and floating charge
    Erstellt am 13. Okt. 2003
    Geliefert am 21. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge all its right, title, interest and benefit in and to the collection account, all monies standing to the credit of the collections account, all right, title, interest and benefit of the charging company in and to the receivables. By way of first floating charge all the sfa stock whatsoever and wheresoever present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and fixed and floating charge
    Erstellt am 20. Mai 2003
    Geliefert am 05. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gmac Commercial Finance PLC
    Transaktionen
    • 05. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Mai 2003
    Geliefert am 31. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Brett Palos
    Transaktionen
    • 31. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Okt. 2003Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 09. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat STATIONERY TRADING UK LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    22. Juli 2010Ende der Verwaltung
    21. Juli 2009Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Andrew Ellis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praktiker
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Lyn L Vardy
    1 East Parade
    S1 2ET Sheffield
    South Yorkshire
    Praktiker
    1 East Parade
    S1 2ET Sheffield
    South Yorkshire
    2
    DatumTyp
    07. Juli 2011Aufgelöst am
    22. Juli 2010Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Andrew Ellis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Ian David Green
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praktiker
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Lyn L Vardy
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0