WYKEHAM HOMES (TORBAY) LIMITED

WYKEHAM HOMES (TORBAY) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWYKEHAM HOMES (TORBAY) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04626467
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WYKEHAM HOMES (TORBAY) LIMITED?

    • (7011) /
    • (7020) /

    Wo befindet sich WYKEHAM HOMES (TORBAY) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Alston Hall
    Holbeton
    PL8 1HN Plymouth
    Devon
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WYKEHAM HOMES (TORBAY) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GRADUATION LIMITED31. Dez. 200231. Dez. 2002

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WYKEHAM HOMES (TORBAY) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für WYKEHAM HOMES (TORBAY) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Beendigung der Bestellung von John Francis Ormond Steven als Geschäftsführer am 04. Mai 2012

    1 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 24. Okt. 2011

    2 Seiten3.6

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2010

    4 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenLQ01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 52 Faraday Mill Business Park, Faraday Road Plymouth PL4 0st United Kingdom am 11. Mai 2010

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. März 2010

    Kapitalaufstellung am 01. März 2010

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2009

    4 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten190

    legacy

    1 Seiten353

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007

    4 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2006

    11 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    Seiten395

    legacy

    Seiten395

    legacy

    Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von WYKEHAM HOMES (TORBAY) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COWE, Carol Ann
    The Cottage
    Newton Hill
    PL8 1AB Newton Ferrers
    Devon
    Sekretär
    The Cottage
    Newton Hill
    PL8 1AB Newton Ferrers
    Devon
    British162713830001
    HOLDER, Robert Douglas
    34 Looseleigh Lane
    PL6 5HQ Plymouth
    Devon
    Sekretär
    34 Looseleigh Lane
    PL6 5HQ Plymouth
    Devon
    British82308350001
    LAMBOURNE, Elizabeth Jane
    8a Gascoyne Place
    PL4 8DF Plymouth
    Devon
    Sekretär
    8a Gascoyne Place
    PL4 8DF Plymouth
    Devon
    British82279680001
    LEIGH, Steven Paul
    1 Mary Street
    Bovey Tracey
    TQ13 9HE Devon
    Sekretär
    1 Mary Street
    Bovey Tracey
    TQ13 9HE Devon
    British109255930001
    SHAW, Hannah
    28 St. Georges Avenue
    PL2 3PW Plymouth
    Sekretär
    28 St. Georges Avenue
    PL2 3PW Plymouth
    British118565860001
    BRISTOL LEGAL SERVICES LIMITED
    Pembroke House
    7 Brunswick Square
    BS2 8PE Bristol
    Avon
    Bevollmächtigter Sekretär
    Pembroke House
    7 Brunswick Square
    BS2 8PE Bristol
    Avon
    900001040001
    GURNEY, Charles Alfred
    Yolland Barn
    Down Thomas
    PL9 0DX Plymouth
    Devon
    Geschäftsführer
    Yolland Barn
    Down Thomas
    PL9 0DX Plymouth
    Devon
    United KingdomBritish92711240001
    STEVEN, John Francis Ormond
    Alston Hall
    Holbeton
    PL8 1HN Plymouth
    Devon
    Geschäftsführer
    Alston Hall
    Holbeton
    PL8 1HN Plymouth
    Devon
    United KingdomBritish107570880001
    BOURSE NOMINEES LIMITED
    Pembroke House
    7 Brunswick Square
    BS2 8PE Bristol
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Pembroke House
    7 Brunswick Square
    BS2 8PE Bristol
    900016940001

    Hat WYKEHAM HOMES (TORBAY) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge of shares
    Erstellt am 18. Feb. 2008
    Geliefert am 28. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £300,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Two ordinary shares of £1 each in dummer golf club limited.
    Berechtigte Personen
    • Vine Leisure Limited
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 18. Feb. 2008
    Geliefert am 28. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £300,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All land goodwill and uncalled capital the securities insurances and debts see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Vine Leisure Limited
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Feb. 2008
    Geliefert am 28. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £300,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The torbay clinic torbay devon t/no DN170486.
    Berechtigte Personen
    • Vine Leisure Limited
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Apr. 2005
    Geliefert am 04. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings k/a the torbay clinic st lukes road torquay t/n DN170489 all rights to and interest in any insurances in respect of the property the gross rents licence fees and other monies receivable in respect of the property (the rental income) all interest and rights under any contracts or agreements or claims for or in respect of the sale purchase leasing mortgaging management carrying out of works to development or redevelopment of or other dealing with or ownership of the property or any part thereof the goodwill of any business and floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 129. Okt. 2010Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
      • Aktenzeichen 1
    Floating charge
    Erstellt am 28. Apr. 2005
    Geliefert am 04. Mai 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 28. Apr. 2005
    Geliefert am 29. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rowe & Co Cornwall (Holding) Limited
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Apr. 2005
    Geliefert am 29. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the torbay clinic, st lukes road, torquay. T/no DN170489 by way of fixed charge all its rights to and interest in any insurances, the gross rents licence fees and other monies receivable arising in respect of the property but excluding insurance rents or service charges. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rowe & Co Cornwall (Holdings) Limited
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Juni 2004
    Geliefert am 29. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The torbay clinic t/n DN170489.
    Berechtigte Personen
    • Vine Developments Limited and Christine Higgins
    Transaktionen
    • 29. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Juni 2004
    Geliefert am 19. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a the torbay clinic st lukes road south torquay devon TQ2 5NZ t/n DN170489. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Apr. 2004
    Geliefert am 27. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Apr. 2003
    Geliefert am 08. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £350,000 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Vine Developments Limited and Christine Anne Higgins
    Transaktionen
    • 08. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Okt. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat WYKEHAM HOMES (TORBAY) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Nicolas Sean Jones
    Brunswick House Brunswick Place
    SO15 2AP Southampton
    Hampshire
    Receiver Manager
    Brunswick House Brunswick Place
    SO15 2AP Southampton
    Hampshire
    Stuart Anthony Jones
    Brunswick House
    Brunswick Place
    Southampton
    So15 2ap
    Receiver Manager
    Brunswick House
    Brunswick Place
    Southampton
    So15 2ap

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0