2016 GGF LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    Unternehmensname2016 GGF LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04639243
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von 2016 GGF LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich 2016 GGF LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von 2016 GGF LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GALA GROUP FINANCE LIMITED10. Aug. 201610. Aug. 2016
    GALA GROUP FINANCE PLC23. Mai 201123. Mai 2011
    GALA GROUP FINANCE LIMITED10. Apr. 200310. Apr. 2003
    STOREREPAIR LIMITED16. Jan. 200316. Jan. 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 2016 GGF LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis26. Sept. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für 2016 GGF LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    24 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom New Castle House Castle Boulevard Nottingham Nottinghamshire NG7 1FT England zum Suite a 7th Floor City Gate East Tollhouse Hill Nottingham NG1 5FS am 04. Apr. 2017

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. März 2017

    LRESSP

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    10 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 046392430013 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2016 bis 31. März 2017

    1 SeitenAA01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed gala group finance LIMITED\certificate issued on 02/12/16
    3 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 22. Nov. 2016

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 02. Nov. 2016

    • Kapital: GBP 20.000119
    5 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cancellation of the share premium account 02/11/2016
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beendigung der Bestellung von Carl Anthony Leaver als Geschäftsführer am 31. Okt. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Gala Coral Secretaries Limited als Sekretär am 13. Sept. 2016

    1 SeitenTM02

    Bescheinigung über die Umregistrierung von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

    1 SeitenCERT10

    Neuregistrierung von Gesellschaftsvertrag und Satzung

    9 SeitenMAR

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Umregistrierung

    RES02

    Umwandlung von einer Aktiengesellschaft in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

    1 SeitenRR02

    Wer sind die Geschäftsführer von 2016 GGF LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BOWTELL, Paul
    City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Suite A 7th Floor
    Geschäftsführer
    City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Suite A 7th Floor
    United KingdomBritish164343080001
    TEMPLEMAN, Robert William
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish159382420002
    WILLITS, Harry Andrew
    City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Suite A 7th Floor
    Geschäftsführer
    City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Suite A 7th Floor
    United KingdomBritish175965490001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Sekretär
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    SINTON, Charles Blair Ritchie
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    Sekretär
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    British52292450003
    SMERDON, Leigh
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Sekretär
    1 Cedar Grove
    The Hedgerows Great Wyrley
    WS6 6QH Walsall
    West Midlands
    Other89075910001
    GALA CORAL SECRETARIES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Sekretär
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    69240850005
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CRONK, John Julian Tristam
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    British6422100001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Newcastle House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Newcastle House
    United Kingdom
    United KingdomBritish21686380006
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish21686380006
    HARRISON, Dominic Stephen
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    United KingdomBritish107909600001
    HARRISON, Dominic Stephen
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Vicarage Drive
    IG11 7NS Barking
    Essex
    United KingdomBritish107909600001
    HUGHES, Gary William
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    ScotlandBritish151269910001
    KELLY, John Michael
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish141916500001
    LEAVER, Carl Anthony
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    Geschäftsführer
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish159381090001
    MATTINGLEY, Brian Roger
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    York House
    Kennedy Close
    SL7 3JA Marlow
    Buckinghamshire
    British22417130001
    ROBERTS, Edward Matthew Giles
    Gala Group Limited
    New Castle House Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Gala Group Limited
    New Castle House Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    British100607290001
    SINTON, Charles Blair Ritchie
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Mill House
    Old Mill Lane
    SL6 2BG Bray
    Berkshire
    United KingdomBritish52292450003
    SOWERBY, Richard Thomas Neville
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish47734920003
    GALA CORAL NOMINEES LIMITED
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    71 Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    76454320002
    GALA CORAL PROPERTIES LIMITED
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Geschäftsführer
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer3720332
    154706560001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei 2016 GGF LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    England
    06. Apr. 2016
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    New Castle House
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer04639011
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat 2016 GGF LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 03. Nov. 2015
    Geliefert am 11. Nov. 2015
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (And Its Successors in Title and Permitted Transferees).
    Transaktionen
    • 11. Nov. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 25. Feb. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Supplemental legal charge supplemental to a debenture dated 27 may 2011 and
    Erstellt am 09. Mai 2012
    Geliefert am 17. Mai 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from an original chargor or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H 71 queensway, london t/no NGL858170.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 17. Mai 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Feb. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 21. Dez. 2011
    Geliefert am 22. Dez. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the shares and all related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (Acting as Security Agent)
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Feb. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 27. Mai 2011
    Geliefert am 10. Juni 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from a chargor or any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (Acting as Security Agent)
    Transaktionen
    • 10. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Feb. 2014Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 24. Sept. 2015Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    • 05. Jan. 2016Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde freigegeben und ist nicht mehr Teil der Belastung (MR05)
    • 25. Feb. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over accounts
    Erstellt am 30. Sept. 2010
    Geliefert am 05. Okt. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge the accounts all its present and future right title and interest in or to the accounts and all amounts now or in the future standing to the credit of or accured or accruing on the accounts see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Feb. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over account in relation to bilateral letter of credit arrangements
    Erstellt am 08. Sept. 2010
    Geliefert am 10. Sept. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor with full title guarantee and as security for the payment of all secured obligations charges in favour of the chargee by way of first fixed charge the account all its present and future right title and interest in or ot the account and all amounts now or in the future standing to the credit account see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over account in relation to letters of credit issued by the chargee under the senior facilities agreement
    Erstellt am 08. Sept. 2010
    Geliefert am 10. Sept. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the accounts and all amounts standing to the credit on the accounts. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 11. Mai 2006
    Geliefert am 24. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 24. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 06. Okt. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 08. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 27. Okt. 2005
    Geliefert am 09. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 09. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Sept. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 06. Okt. 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 08. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 01. Sept. 2005
    Geliefert am 20. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H high street acton london t/no AGL114684, f/h high street aldershot hants t/no HP517737, f/h anchor road aldridge walsall t/no WM167521 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Dez. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of deposit
    Erstellt am 01. Sept. 2005
    Geliefert am 07. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All deposits now and in the future credited to account designation 10264912 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 11. Feb. 2005
    Geliefert am 18. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Benefit of the Senior Financeparties and the Mezzanine Finance Parties
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Sept. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating security document
    Erstellt am 07. Feb. 2003
    Geliefert am 13. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party or any mezzanine finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston London Branch as Security Trustee for the Benefit of the Financeparties
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat 2016 GGF LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    23. Aug. 2018Aufgelöst am
    10. März 2017Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Dilip K Dattani
    Suite A, 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Praktiker
    Suite A, 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Patrick B Ellward
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire
    Praktiker
    Suite A 7th Floor City Gate East
    Tollhouse Hill
    NG1 5FS Nottingham
    Nottinghamshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0