ROLFE & NOLAN GROUP LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ROLFE & NOLAN GROUP LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04641157 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ROLFE & NOLAN GROUP LIMITED?
- Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Aktivitäten (63110) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich ROLFE & NOLAN GROUP LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o LEVEL 26 30 St. Mary Axe EC3A 8EP London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ROLFE & NOLAN GROUP LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
MAIA HOLDINGS LIMITED | 28. Jan. 2003 | 28. Jan. 2003 |
LAW 2390 LIMITED | 20. Jan. 2003 | 20. Jan. 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROLFE & NOLAN GROUP LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ROLFE & NOLAN GROUP LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 046411570012 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 04. Nov. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 046411570013 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Ashley Graham Woods als Direktor am 26. Juni 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Aram John Hoare als Geschäftsführer am 26. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 046411570011 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 046411570010 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 046411570012 | 21 Seiten | MR01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 046411570013 | 22 Seiten | MR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Keith Grehan als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Conor Gerard Clinch als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Keith William Grehan am 01. Jan. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ROLFE & NOLAN GROUP LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOODS, Ashley Graham | Sekretär | c/o Level 26 St. Mary Axe EC3A 8EP London 30 United Kingdom | 181091150001 | |||||||
CLINCH, Conor Gerard | Geschäftsführer | c/o Level 26 St. Mary Axe EC3A 8EP London 30 | Ireland | Irish | Accountant | 188231340001 | ||||
WOODS, Ashley Graham | Geschäftsführer | c/o Level 26 St. Mary Axe EC3A 8EP London 30 | England | Australian | Solicitor | 195520510001 | ||||
ASAA, Liesl | Sekretär | The Gasworks Barrow Street Dublin 4 59 William Bligh Ireland | Irish | Solicitor | 136091870001 | |||||
FREEMAN, Robert Neil | Sekretär | Asha 12a Valkyrie Avenue CT5 4DJ Whitstable Kent | British | Company Director | 122758450001 | |||||
LACEY, Stephen | Sekretär | The Coach House Hungershall Park TN4 8ND Tunbridge Wells Kent | British | Accountant | 88368490002 | |||||
TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 84071220001 | |||||||
DEE, Leo Mark | Geschäftsführer | 1 Howard Walk N2 0HB London | British | Fund Manager | 70390630002 | |||||
FREEMAN, Robert Neil | Geschäftsführer | Eden Road Seasalter CT5 4AP Whitstable Eden Lodge 2a Kent | England | British | Company Director | 122758450002 | ||||
GREHAN, Keith William | Geschäftsführer | c/o Level 26 St. Mary Axe EC3A 8EP London 30 United Kingdom | United Kingdom | Irish | Financial Consultant | 161598880001 | ||||
HAMER, John Ridgley | Geschäftsführer | The Lake House Mill Lane Chiddingfold GU8 4SJ Godalming Surrey | United Kingdom | British | Consultant | 8323300003 | ||||
HARRISON, Steven Peter | Geschäftsführer | 46 Kelmscott Road SW11 6QY London | England | British | Engineer | 69272540002 | ||||
HEARLEY, Timothy Michael | Geschäftsführer | Rush Leys 4 Birds Hill Rise Oxshott KT22 0SW Leatherhead Surrey | England | British | Company Director | 47903210001 | ||||
HOARE, Aram John | Geschäftsführer | c/o Level 26 St. Mary Axe EC3A 8EP London 30 United Kingdom | Ireland | Australian | Lawyer | 152785810001 | ||||
HUMPHRIES, Nicholas James | Geschäftsführer | 43 Park Avenue Hutton CM13 2QP Brentwood Essex | British | Fund Manager | 57329660001 | |||||
KING, Alexander | Geschäftsführer | 79 Beaufort Mansions Beaufort Street SW3 5AF London | British | Fund Manager | 108098260002 | |||||
LACEY, Stephen | Geschäftsführer | The Coach House Hungershall Park TN4 8ND Tunbridge Wells Kent | England | British | Accountant | 88368490002 | ||||
SHIVANANDA, Alexander | Geschäftsführer | 58 Fitzjohns Avenue NW3 5LT London | British | Fund Manager | 102312930001 | |||||
HUNTSMOOR LIMITED | Geschäftsführer | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 39090660001 | |||||||
HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Carmelite 50 Victoria Embankment EC4Y 0DX Blackfriars London | 41864110001 |
Hat ROLFE & NOLAN GROUP LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 10. Juni 2014 Geliefert am 19. Juni 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Belastungsgrundlage als Bare Trust: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 10. Juni 2014 Geliefert am 19. Juni 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Belastungsgrundlage als Bare Trust: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 22. Mai 2013 Geliefert am 03. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 22. Mai 2013 Geliefert am 03. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Amended and restated debenture | Erstellt am 23. Aug. 2007 Geliefert am 31. Aug. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital land and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. Juni 2007 Geliefert am 12. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charges over all of the present and future assets, land, equipment, goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 29. Sept. 2006 Geliefert am 18. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a 3RD, 4TH, 5TH and 6TH floors, 120 leman street, london. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An omnibus letter of set-off | Erstellt am 07. Apr. 2006 Geliefert am 12. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 14. Dez. 2004 Geliefert am 17. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each of the companies to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage of life policy | Erstellt am 11. Juni 2003 Geliefert am 13. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All money including bonuses under the policy. The benefit of all options in connection with the policy and all the rights and interest in the policy. Policy re: neil freeman for an amount of £1,000,000 policy no: 28C82 B88. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage of life policy | Erstellt am 11. Juni 2003 Geliefert am 13. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money including bonuses under the policy. The benefit of all options and right in connection with the policy and all rights and interest in the policy | |
Kurze Angaben All money including bonuses under the policy. The benefit of all options in connection with the policy and all the rights and interest in the policy. Policy re: robert edward sylverne for an amount of £600,000 policy no: 28C94 L37. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage of life policy | Erstellt am 11. Juni 2003 Geliefert am 13. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All money including bonuses under the policy. The benefit of all options and rights in connection with the policy. All the company's rights and interest in the policy. Policy re: james michael birney for an amount of £600,000 policy no: 28C94 X33. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture deed | Erstellt am 27. Feb. 2003 Geliefert am 13. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0