ACACIA PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameACACIA PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04647551
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ACACIA PROPERTIES LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich ACACIA PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3 Hardman Street
    M3 3AT Spinningfields
    Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ACACIA PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für ACACIA PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    21 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Sept. 2020

    18 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Sept. 2019

    16 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Sept. 2018

    18 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Sept. 2017

    18 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Sept. 2016

    18 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:sec of state cert release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:replacement liquidators.
    7 SeitenLIQ MISC OC

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Sept. 2015

    13 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 20. Sept. 2014

    14 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Sept. 2014

    12 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    3 Seiten2.23B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 20. März 2014

    13 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. Okt. 2013

    7 Seiten2.24B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Bdo Llp 3 Hardman Street Spinningfields Manchester Greater Manchester M3 3HJ* am 13. Juni 2013

    2 SeitenAD01

    Vorschlag des Verwalters

    30 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 1 Bell Street 2Nd Floor London NW1 5BY United Kingdom* am 13. Mai 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Wer sind die Geschäftsführer von ACACIA PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SHAH, Sobakchand Ramji
    54 Ladbroke Drive
    EN6 1QW Potters Bar
    Hertfordshire
    Sekretär
    54 Ladbroke Drive
    EN6 1QW Potters Bar
    Hertfordshire
    BritishDirector76081060002
    SHAH, Manjula
    54 Ladbrooke Drive
    EN6 1QW Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    54 Ladbrooke Drive
    EN6 1QW Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAdministrator91525370003
    SHAH, Sobakchand Ramji
    54 Ladbroke Drive
    EN6 1QW Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    54 Ladbroke Drive
    EN6 1QW Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector76081060002
    SHAH, Poonam
    Aanand Nivas
    Manor Way
    EN6 1EE Potters Bar
    Hertfordshire
    Sekretär
    Aanand Nivas
    Manor Way
    EN6 1EE Potters Bar
    Hertfordshire
    IndianAccounts Assistant75515420001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    SHAH, Meena
    31 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    31 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    BritishSecretary75515390001
    SHAH, Poonam
    Aanand Nivas
    Manor Way
    EN6 1EE Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Aanand Nivas
    Manor Way
    EN6 1EE Potters Bar
    Hertfordshire
    IndianAccounts Assistant75515420001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Hat ACACIA PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Assingnment of rents
    Erstellt am 07. Jan. 2008
    Geliefert am 10. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Rental sums fixed charge in the deposit and the rental account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Newcastle Building Society
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 07. Jan. 2008
    Geliefert am 10. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of floating charge the charged assets, being all the undertaking property and assets of the company present and future.
    Berechtigte Personen
    • Newcastle Building Society
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 07. Jan. 2008
    Geliefert am 10. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H 124-126 and 128-130 high street stevenage t/no HD4392.
    Berechtigte Personen
    • Newcastle Building Society
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 19. Dez. 2007
    Geliefert am 03. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of floating charge all assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • West Bromwich Commercial Limited
    Transaktionen
    • 03. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Standard security presented for registration in scotland on 21 december 2007 and
    Erstellt am 17. Dez. 2007
    Geliefert am 08. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fifty five fifty seven and fifty nine upper craigs stirling t/n STG23791.
    Berechtigte Personen
    • West Bromwich Commercial Limited
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 03. Nov. 2006
    Geliefert am 07. Nov. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    106 high street eltham t/no 34972 together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery.the benefit of all guarantees indemnities rent deposits.by way of assignment the goodwill of the business and all monies due in relation to contracts or policies of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of rental assignment
    Erstellt am 03. Nov. 2006
    Geliefert am 07. Nov. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title benefit and interest of the company in and to all rent, licence fees or other sums received by the company from any tenant or licensee of the property (see form 395 for details). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 07. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 2006
    Geliefert am 04. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Property k/a 19 high street, petersfield, hampshire t/no HP368820.
    Berechtigte Personen
    • West Bromwich Commercial Limited
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of rental income
    Erstellt am 25. Jan. 2006
    Geliefert am 04. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The right to receive all rents in respect of the property k/a 19 high street, petersfield, hampshire t/no HP368820.
    Berechtigte Personen
    • West Bromwich Commercial Limited
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 10. Apr. 2003
    Geliefert am 15. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Floating charge all the undertaking property and assets of the company present and future but excluding any property which is at any time subject to any effectual fixed legal charge in favour of the society (except where such property becomes the subject of such a fixed charge as a result of the crystallisation of this floating charge).
    Berechtigte Personen
    • West Bromwich Building Society
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Erstellt am 10. Apr. 2003
    Geliefert am 15. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to the commercial mortgage deed dated 10TH april 2003
    Kurze Angaben
    Exclusive rights of the company to receive all rent in respect of the property at 19 high street petersfield hampshire with title number HP368820.
    Berechtigte Personen
    • West Bromwich Building Society
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Commercial mortgage deed
    Erstellt am 10. Apr. 2003
    Geliefert am 15. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Kurze Angaben
    Freehold property known as 19 high street petersfield hampshire with title number HP368820 together with all goodwill of the business benefit of all licences any compensation payable thereunder any shareholding issued or to be issued to the company in any management company or similar association present and future uncalled share capital all land (except the property) vested in or charged to the company or to which the company is otherwise entitled benefit of licences thereof all rental and other monies in relation thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • West Bromwich Building Society
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Hat ACACIA PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    04. Apr. 2013Beginn der Verwaltung
    26. Sept. 2014Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kerry Bailey
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3HF Manchester
    Anne Buchanan
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    2
    DatumTyp
    26. Sept. 2014Beginn der Liquidation
    01. Okt. 2021Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anne Buchanan
    4 Atlantic Quay, 70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Vorgeschlagener Liquidator
    4 Atlantic Quay, 70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Kerry Bailey
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3HF Manchester
    Vorgeschlagener Liquidator
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3HF Manchester
    Sarah Megan Rayment
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0