TP SHELFCO NO.2 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TP SHELFCO NO.2 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04647961 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TP SHELFCO NO.2 LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich TP SHELFCO NO.2 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square B3 3AX Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TP SHELFCO NO.2 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BIRCHWOOD GROUP HOLDINGS LIMITED | 23. Juni 2003 | 23. Juni 2003 |
| EVER 2030 LIMITED | 27. Jan. 2003 | 27. Jan. 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TP SHELFCO NO.2 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TP SHELFCO NO.2 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 11 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG zum C/O Mazars Llp 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX am 29. Sept. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Cessation of The Bss Group Limited as a person with significant control on 27. Aug. 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Notification of Travis Perkins Financing Company No.3 Limited as a person with significant control on 27. Aug. 2021 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Deborah Grimason als Geschäftsführer am 06. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Peter Carter als Geschäftsführer am 18. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Miss Deborah Grimason als Direktor am 18. Juli 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony David Buffin als Geschäftsführer am 11. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Alan Richard Williams als Direktor am 11. Juli 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TP SHELFCO NO.2 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, Alan Richard | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 137582690004 | |||||||||
| TP DIRECTORS LTD | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
| BALL, Ute Suse | Sekretär | Lee Circle LE1 3QQ Leicester Fleet House | British | 118371550001 | ||||||||||
| BOLLU, Pierre | Sekretär | 20 Lime Grove Avenue NG9 4AR Chilwell Nottinghamshire | British | 92317380001 | ||||||||||
| PIKE, Andrew Stephen | Sekretär | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | 158166450001 | |||||||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023530001 | |||||||||||
| ALLEN, Timothy Peter | Geschäftsführer | Barton Park House Ashbourne Road DE65 5AT Church Broughton Derbyshire | England | British | 92777740001 | |||||||||
| BUFFIN, Anthony David | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | England | British | 178011680002 | |||||||||
| CARTER, John Peter | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 46226920007 | |||||||||
| COOPER, Geoffrey Ian | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 104472550001 | |||||||||
| GREATOREX, Sue | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 177194840001 | |||||||||
| GRIMASON, Deborah | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House | England | British | 185755960002 | |||||||||
| HAMPDEN SMITH, Paul Nigel | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 72135950007 | |||||||||
| MURRAY, John Roderick | Geschäftsführer | Lee Circle LE1 3QQ Leicester Fleet House | United Kingdom | British | 145111310001 | |||||||||
| SIMONS, John Barry | Geschäftsführer | 28 Bromyard Terrace St Johns WR2 5BW Worcester Worcestershire | United Kingdom | British | 94492900001 | |||||||||
| SLARK, Gavin | Geschäftsführer | Lee Circle LE1 3QQ Leicester Fleet House | United Kingdom | British | 162972090001 | |||||||||
| SMITH, Anthony Edward | Geschäftsführer | Bonita House 11 Risborrow Close DE65 6HY Etwall Derbyshire | United Kingdom | British | 36984820004 | |||||||||
| TALLENTIRE, Paul John | Geschäftsführer | Lee Circle LE1 3QQ Leicester Fleet House Leicestershire United Kingdom | England | British | 134335900002 | |||||||||
| EVERDIRECTOR LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 900023520001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TP SHELFCO NO.2 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Perkins Financing Company No.3 Limited | 27. Aug. 2021 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| The Bss Group Limited | 06. Apr. 2016 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat TP SHELFCO NO.2 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Mai 2006 Geliefert am 11. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 02. Mai 2006 Geliefert am 12. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H birch park park lodge road giltbrook nottingham t/n nt 406041. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Mai 2006 Geliefert am 11. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H property on the south west side of halls lane, giltbrook, broxtowe, nottingham and k/a birch park, park lodge road, giltbrook, nottingham t/no. NT406041. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Sept. 2005 Geliefert am 05. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land on the south west side of halls lane giltbrook nottingham now k/a dyggor gaylord house birch park park lodge road giltbrook nottingham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Okt. 2003 Geliefert am 13. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All f/h and l/h property of the chargor situate in england and wales and all liens, charges, options, agreements, rights and interests in or over land or the proceeds of sale of land, and all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time on such property or land. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Okt. 2003 Geliefert am 11. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and all other companies named therein to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TP SHELFCO NO.2 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0