SILK INDUSTRIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSILK INDUSTRIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04667190
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SILK INDUSTRIES LIMITED?

    • Weben von Textilien (13200) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich SILK INDUSTRIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O INTERPATH ADVISORY
    60 Grey Street
    NE1 6AH Newcastle Upon Tyne
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SILK INDUSTRIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TAYVIN 300 LIMITED17. Feb. 200317. Feb. 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SILK INDUSTRIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für SILK INDUSTRIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    28 SeitenAM10
    YC92D3QG

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    28 SeitenAM23
    YC92D4F7

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    28 SeitenAM10
    YC4PYSFM

    Erfüllung der Belastung 046671900013 vollständig

    1 SeitenMR04
    XBVLXUIR

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    29 SeitenAM10
    YBHQU3UG

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19
    YBCG8SRV

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    29 SeitenAM10
    YB4VFOBN

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Quayside House 110 Quayside Newcastle-upon-Tyne NE1 3DX zum 60 Grey Street Newcastle upon Tyne NE1 6AH am 17. Dez. 2021

    2 SeitenAD01
    YAIYUWDU

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    29 SeitenAM10
    YAID0RGX

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19
    AAE6VYYH

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    36 SeitenAM10
    YA5FL40L

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    3 SeitenAM06
    Y9WO5JY3

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    2 SeitenMR04
    X9WLDBNM

    Vorschlag des Verwalters

    45 SeitenAM03
    Y9VHFWUP

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA/AM02SOC

    22 SeitenAM02
    Y9K6OUDM

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Gregory Mills Weavers Lane Sudbury Suffolk CO10 1BB zum Quayside House 110 Quayside Newcastle-upon-Tyne NE1 3DX am 05. Dez. 2020

    2 SeitenAD01
    Y9HNXTUH

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    2 SeitenMR04
    X9J2NQ8B

    Ernennung eines Verwalters

    3 SeitenAM01
    Y9HNXTUX

    Beendigung der Bestellung von Tro Steven Manoukian als Geschäftsführer am 09. Nov. 2020

    1 SeitenTM01
    X9HFTNEP

    Eintragung der Belastung 046671900013, erstellt am 12. März 2020

    41 SeitenMR01
    X910H8OR

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    2 SeitenMR04
    X90XOVGQ

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    2 SeitenMR04
    X90XOVTC

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01
    X909YD2X

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2019

    51 SeitenAA
    X8XUB8MX

    Wer sind die Geschäftsführer von SILK INDUSTRIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    OXLEY, Steven Anthony
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Gregory Mills
    Suffolk
    United Kingdom
    Sekretär
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Gregory Mills
    Suffolk
    United Kingdom
    245961830001
    GORE, Laura Jayn
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Gregory Mills
    Suffolk
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Gregory Mills
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritishSales Director245961660001
    OXLEY, Steven Anthony
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Gregory Mills
    Suffolk
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Gregory Mills
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector38082370001
    TOOTH, David Eric
    Grey Street
    NE1 6AH Newcastle Upon Tyne
    60
    Geschäftsführer
    Grey Street
    NE1 6AH Newcastle Upon Tyne
    60
    EnglandBritishCompany Chairman13094080001
    SHORT, John Richard
    The Cottage Church Lane
    Lolworth
    CB23 8HE Cambridge
    Sekretär
    The Cottage Church Lane
    Lolworth
    CB23 8HE Cambridge
    British8407810001
    STEVENSON, Ian Richard
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    Sekretär
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    159157240001
    WELSH, Terence Melvin
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    Sekretär
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    BritishAccountant92194750001
    BECK, Martin William
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    EnglandBritishChartered Accountant34405720002
    BRACE, Dean Terence
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    EnglandBritishManager185676030001
    CLARKE, Doreen Patricia
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    EnglandBritishDirector92194800001
    CLAYTON, Steven Stewart
    6 Lakeside
    Bosley
    SK11 0PL Macclesfield
    Cheshire
    Geschäftsführer
    6 Lakeside
    Bosley
    SK11 0PL Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritishSales Manager92194110001
    CROFT, Rosemarie Avis
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    EnglandBritishSecretary92194920001
    GOLDER, Quentin Robert
    17 Broad Lane
    Haslingfield
    CB3 7JF Cambridge
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    17 Broad Lane
    Haslingfield
    CB3 7JF Cambridge
    Cambridgeshire
    EnglandNew ZealanderSolicitor73684700001
    HENRY, Andrew Cameron David
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    EnglandBritishSales Manager92194470002
    HUBERT, Mark James
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    EnglandBritishDesign Director92194370003
    JEGGO, Thomas Charles
    St. Aubins House
    Cock Road Little Maplestead
    CO9 2SH Halstead
    Essex
    Geschäftsführer
    St. Aubins House
    Cock Road Little Maplestead
    CO9 2SH Halstead
    Essex
    BritishProduction Director92194640001
    KING, David Alan Alfred
    Bramble Cottage
    Whitestreet Green
    CO10 5JL Boxford
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Bramble Cottage
    Whitestreet Green
    CO10 5JL Boxford
    Suffolk
    BritishDirector99227310001
    MANOUKIAN, Tro
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Gregory Mills
    Suffolk
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Gregory Mills
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector211400130001
    MANOUKIAN, Tro
    22 Rook Street
    St Marys Courtyard
    M15 5PS Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    22 Rook Street
    St Marys Courtyard
    M15 5PS Manchester
    Lancashire
    BritishGeneral Manager124344750001
    MILES, Laura Jane
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritishTextile Designer142793100001
    NIXON, Stephen Andrew
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    EnglandBritishDesign Director92194320001
    REEKS, Alexander Clive
    The Acorn 4 Pelhams Walk
    KT10 8QD Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Acorn 4 Pelhams Walk
    KT10 8QD Esher
    Surrey
    BritishDirector44676850002
    SHORT, John Richard
    The Cottage Church Lane
    Lolworth
    CB23 8HE Cambridge
    Geschäftsführer
    The Cottage Church Lane
    Lolworth
    CB23 8HE Cambridge
    United KingdomBritish8407810001
    STEVENSON, Ian Richard
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritishManaging Director159158930001
    WELSH, Terence Melvin
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Gregory Mills
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Suffolk
    EnglandBritishAccountant92194750001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SILK INDUSTRIES LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mrs Susan Tooth
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Gregory Mills
    Suffolk
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Gregory Mills
    Suffolk
    United Kingdom
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 25%, aber nicht mehr als 50% der Stimmrechte im Unternehmen.
    Mr David Eric Tooth
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Gregory Mills
    Suffolk
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Weavers Lane
    CO10 1BB Sudbury
    Gregory Mills
    Suffolk
    United Kingdom
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 50%, aber nicht mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 50%, aber nicht mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat SILK INDUSTRIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 12. März 2020
    Geliefert am 17. März 2020
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    The company, as continuing security for the payment, discharge and performance of all the secured obligations in relation to all of the following assets whether now or in future belonging to the company hereby, in each case with full title guarantee:. (A) fixed charges: charges to igf business credit limited by way of separate fixed charges:. (I) by way of legal mortgage (1) the property at gregory mills, weavers lane, sudbury, suffolk CO10 1BB registered at hm land registry with title number SK100375 and (2) the land and premises lying to the west of gregory street, sudbury registered at hm land registry with title number SK99669;. (Ii) by way of equitable mortgage its real property, other than the property or properties specified in schedule 1;. real property means all freehold and leasehold properties and other real property both present and future (including the property or properties specified in schedule 2 and set opposite its name) of the company including all buildings and other structures from time to time erected thereon and all fixtures (trade or otherwise) from time to time thereon or therein.. (Iii) all its intellectual property listed in schedule 2 of the debenture and all other intellectual property other than that listed in schedule 2;. intellectual property means in relation to the company, all patents (including applications for and rights to apply for patents), trademarks and service marks (whether registered or not) and applications for the same, trade names, registered designs, design rights, semi-conductor topography rights, database rights, copyrights, computer programs, know-how and trade secrets and all other intellectual or intangible property or rights and all licences, agreements and ancillary and connected rights relating to intellectual and intangible property including any renewals, revivals or extensions thereof and wherever in the world subsisting.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Igf Business Credit Limited
    Transaktionen
    • 17. März 2020Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 20. Jan. 2023Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 20. Juli 2006
    Geliefert am 03. Aug. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The equipment being 2 x "eco-bloc x" yarn dyeing machines, type 800KB, 1 laboratory dyeing machine "eco bloc" type 178/5 s/n's 47581-47589 and 2 x picanol weaving machines, model gammax-8-r-220 cm, machine numbers 279.229 and 279.230 for details of further chattels charged please refer to form 395, together with all replacements, renewals and component parts thereof and all additions and accessories thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 23. Feb. 2005
    Geliefert am 24. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All singular the chattels plant machinery and things described in the schedule being 6 x staubli jacquards machines 880 size with harness s/n's C5 W02B8DA1M01, C11 W028B8DB1M01, A8 W028B8ED, A9 W028B8EB, C4 W028B8 E0 and C10 W028B8EAAND 1 x staubli wrap typing machine tpm-301 s/n 3374G1 for details of further chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Nov. 2003
    Erworben am 30. Apr. 2004
    Geliefert am 10. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as tayvin 300 limited) to the chargee
    Kurze Angaben
    The f/h land known as gregory mills weavers lane sudbury suffolk t/n SK100375,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Juni 2004Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 16. März 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Nov. 2003
    Erworben am 30. Apr. 2004
    Geliefert am 10. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as tayvin 300 limited) to the chargee
    Kurze Angaben
    The f/h land and premises to the west of gregory street sudbury suffolk t/n SK99669,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Juni 2004Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 16. März 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Nov. 2003
    Erworben am 30. Apr. 2004
    Geliefert am 10. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as tayvin 300 limited) to the chargee
    Kurze Angaben
    The land known as river mills langley ma. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Juni 2004Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 07. Nov. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 14. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Third party legal charge
    Erstellt am 13. Nov. 2003
    Erworben am 30. Apr. 2004
    Geliefert am 10. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as tayvin 300 limited) to the chargee
    Kurze Angaben
    The property at weavers lane sudbury suffolk t/n SK100375, the land known as river mills langley macclesfield cheshire t/n CH396683 and land and premises to the west of gregory street sudbury suffolkt/n SK99669, fixed charged all future freehold and leasehold property, goodwill,floating charge over the assets and unde. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clive Reeks
    Transaktionen
    • 10. Juni 2004Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 07. Nov. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 14. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Third party legal charge
    Erstellt am 13. Nov. 2003
    Erworben am 30. Apr. 2004
    Geliefert am 10. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as tayvin 300 limited) to the chargee
    Kurze Angaben
    The property at weavers lane sudbury suffolk t/n SK100375, the land known as river mills langley macclesfield cheshire t/n CH396683 and land and premises to the west of gregory street sudbury suffolk t/n SK99669, fixed charged all future freehold and leasehold property, goodwill floating charge over the assets and undertaking of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • David Tooth
    Transaktionen
    • 10. Juni 2004Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 07. Nov. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 13. Aug. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 13. Nov. 2003
    Erworben am 30. Apr. 2004
    Geliefert am 10. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company (formerly known as tayvin 300 limited) to the chargee
    Kurze Angaben
    Gregory mills weavers lane sudbury t/n SK100375, river mills langley macclesfield cheshire t/n CH396683 and land and premises to the west of gregory street sudbury suffolk t/n SK99669. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Juni 2004Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 07. Nov. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 02. Dez. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 03. Sept. 2003
    Geliefert am 13. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clive Reeks (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Nov. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 19. Nov. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 03. Sept. 2003
    Geliefert am 13. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • David Tooth (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Nov. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 13. Aug. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 02. Sept. 2003
    Geliefert am 13. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat SILK INDUSTRIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Nov. 2020Beginn der Verwaltung
    11. Aug. 2023Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher Robert Pole
    Kpmg Llp One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    Kpmg Llp One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    James Ronald Lumb
    Quayside House 110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    Praktiker
    Quayside House 110 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0