ODEON DDB CO LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameODEON DDB CO LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04676590
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ODEON DDB CO LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich ODEON DDB CO LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    No 1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ODEON DDB CO LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CASTLE DDB CO LIMITED24. Feb. 200324. Feb. 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ODEON DDB CO LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für ODEON DDB CO LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    10 SeitenLIQ13

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Lee House 90 Great Bridgewater Street Manchester M1 5JW verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Lee House 90 Great Bridgewater Street Manchester M1 5JW geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX zum No 1 Colmore Square Birmingham B4 6HQ am 14. Dez. 2017

    2 SeitenAD01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 20. Nov. 2017

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beendigung der Bestellung von Craig Ray Ramsey als Geschäftsführer am 06. Nov. 2017

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr John Brooks Rainer als Direktor am 06. Nov. 2017

    2 SeitenAP01

    Kapitalaufstellung am 02. Okt. 2017

    • Kapital: GBP 0.001
    3 SeitenSH19

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    9 SeitenAA

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Beendigung der Bestellung von Kirsten Lawton als Sekretär am 12. Juli 2017

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Andrew Stephen Alker als Geschäftsführer am 06. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Jonathan Way als Geschäftsführer am 06. Juli 2017

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Craig Ray Ramsey als Direktor am 06. Juli 2017

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. Feb. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Paul Michael Donovan als Geschäftsführer am 30. Nov. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. März 2016

    Kapitalaufstellung am 10. März 2016

    • Kapital: GBP 9,000.001
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    8 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von ODEON DDB CO LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    RAINER, John Brooks
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    Geschäftsführer
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    United StatesAmericanTax Acountant239691240001
    GAZDIG, Grant John Paul
    12 Ashburn House
    35 Collingham Road
    SW5 0NU London
    Sekretär
    12 Ashburn House
    35 Collingham Road
    SW5 0NU London
    CanadianDirector78476440001
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector124301460001
    KACHINGWE, Mayamiko Allen Harrison
    Flat 17
    Buckland Crescent
    NW3 5DH London
    Greater London
    Sekretär
    Flat 17
    Buckland Crescent
    NW3 5DH London
    Greater London
    BritishDirector99741450001
    LAWTON, Kirsten
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    Sekretär
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    BritishChartered Secretary50045660003
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Sekretär
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Sekretär
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Sekretär
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    84071220001
    ALKER, Andrew Stephen
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant120642230001
    CHADD, Andrew Peter
    The Old Pheasantry
    Woodcock Hill
    RH19 2RB Felbridge
    West Sussex
    Geschäftsführer
    The Old Pheasantry
    Woodcock Hill
    RH19 2RB Felbridge
    West Sussex
    United KingdomBritishDirector133578890002
    CLUCAS, Neil Keith
    43 Westcliffe Road
    PR8 2JS Southport
    Merseyside
    Geschäftsführer
    43 Westcliffe Road
    PR8 2JS Southport
    Merseyside
    UkBritishOperations Director Odeon Uci108801550001
    DELLAL, Guy Sulman
    1 Holland Park Avenue
    W11 3RH London
    Geschäftsführer
    1 Holland Park Avenue
    W11 3RH London
    EnglandBritishDirector88802070001
    DONOVAN, Paul Michael
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England And Wales
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England And Wales
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Executive154988050002
    GAVIN, Alexander Rupert, Sir
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    Geschäftsführer
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    United KingdomBritishDirector16875680002
    GAZDIG, Grant John Paul
    12 Ashburn House
    35 Collingham Road
    SW5 0NU London
    Geschäftsführer
    12 Ashburn House
    35 Collingham Road
    SW5 0NU London
    CanadianDirector78476440001
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishAccountant124301460001
    GRAF VON SPONECK, Hans Alexander
    7 Irving Road
    W14 0JT London
    Geschäftsführer
    7 Irving Road
    W14 0JT London
    German UsBanker88801930001
    GREEN, Nigel Graham
    8 Bryman Court
    31-32 Montagu Square
    W1H 2LH London
    Geschäftsführer
    8 Bryman Court
    31-32 Montagu Square
    W1H 2LH London
    EnglandBritishDirector8499810001
    GREEN, Trevor Henry
    7 Nottingham Terrace York Gate
    Regents Park
    NW1 4QB London
    Geschäftsführer
    7 Nottingham Terrace York Gate
    Regents Park
    NW1 4QB London
    United KingdomBritishDirector8499820001
    HARRIS, Roger John
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    Geschäftsführer
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    United KingdomBritishChief Operating Officer129109390001
    KACHINGWE, Mayamiko Allen Harrison
    Flat 17
    Buckland Crescent
    NW3 5DH London
    Greater London
    Geschäftsführer
    Flat 17
    Buckland Crescent
    NW3 5DH London
    Greater London
    BritishDirector99741450001
    LANPHERE, Scott Allen
    Mayles
    12 The Drive
    KT11 2JQ Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Mayles
    12 The Drive
    KT11 2JQ Cobham
    Surrey
    United KingdomAmericanDirector64952610002
    MALONE, Frank
    14a Belgrave Court Canary Riverside
    36 Westferry Circus
    E14 8RJ London
    Geschäftsführer
    14a Belgrave Court Canary Riverside
    36 Westferry Circus
    E14 8RJ London
    IrishBanker95639090001
    MASON, Jonathan Peter
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    Geschäftsführer
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    United KingdomBritishCfo Odeon Uci117783520001
    O'HAIRE, Cormac Patrick Thomas
    Sutherland Road
    Ealing
    W13 0DX London
    17
    Geschäftsführer
    Sutherland Road
    Ealing
    W13 0DX London
    17
    IrishFinance Director89259830001
    PUNJA, Riaz
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    Geschäftsführer
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    United KingdomBritishDirector58870910002
    RAMSEY, Craig Ray
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    Geschäftsführer
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United StatesAmericanExecutive221321960001
    RAYMOND, Jonathan Joseph
    Flat 2 339 Portobello Road
    W10 5SA London
    Geschäftsführer
    Flat 2 339 Portobello Road
    W10 5SA London
    BritishFinancier75801880004
    RITVAY, Alexander Tibor Mihaly, Dr
    Mommsenstrasse 64
    FOREIGN 10629 Berlin
    Germany
    Geschäftsführer
    Mommsenstrasse 64
    FOREIGN 10629 Berlin
    Germany
    GermanLawyer95639320001
    SAUNDERS, Robin Elizabeth
    1 Airlie Gardens
    W8 7AJ London
    Geschäftsführer
    1 Airlie Gardens
    W8 7AJ London
    AmericanDirector108076430001
    SEGAL, Richard Lawrence
    16 Spencer Drive
    N2 0QX London
    Geschäftsführer
    16 Spencer Drive
    N2 0QX London
    EnglandBritishManaging Director47031800003
    TCHENGUIZ, Robert
    6 Chesterfield Hill
    Mayfair
    W1J 5BL London
    Geschäftsführer
    6 Chesterfield Hill
    Mayfair
    W1J 5BL London
    IranianDirector74322720002
    WAIBL, Karin Elisabeth
    Niederkasseler Str. 83
    FOREIGN 40547 Dusseldorf
    Germany
    Geschäftsführer
    Niederkasseler Str. 83
    FOREIGN 40547 Dusseldorf
    Germany
    GermanBanker Lawyer92888700001
    WAY, Mark Jonathan
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant191239860001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ODEON DDB CO LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Odeon Equity Co Limited
    Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House, 57
    England
    06. Apr. 2016
    Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House, 57
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandUk
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortRegister Of Companies, Cardiff
    Registrierungsnummer4676572
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat ODEON DDB CO LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 24. Mai 2011
    Geliefert am 07. Juni 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from odeon & uci bond midco limited or any restricted subsidiary to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Bank of New York Mellon
    Transaktionen
    • 07. Juni 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 04. Apr. 2007
    Geliefert am 16. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's right, title and interest from time to time in and to each of the following assets the material property other than the excluded property the tangible movable property the accounts the intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Mai 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 03. Dez. 2004
    Geliefert am 16. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and any obligor to the chargee (the security agent as agent and trustee for the secured parties), the loan note holder and any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The material property other than the excluded property; the tangible moveable property; the accounts; the intellectual property; any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company; the investments; the shares, all dividends, interest and other monies payable in respect of the shares and all other related rights; all monetary claims and all related rights; and any other contract or agreement to which the company is a party (other than the specific contracts) and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Sept. 2004
    Geliefert am 24. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 07. März 2003
    Geliefert am 26. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from any obligor to the chargee as security trustee for the secured parties (the "security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Westlb Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 26. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ODEON DDB CO LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Nov. 2018Aufgelöst am
    20. Nov. 2017Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Derek Hyslop
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Praktiker
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0