ODEON DDB CO LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ODEON DDB CO LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04676590 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ODEON DDB CO LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ODEON DDB CO LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | No 1 Colmore Square B4 6HQ Birmingham |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ODEON DDB CO LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CASTLE DDB CO LIMITED | 24. Feb. 2003 | 24. Feb. 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ODEON DDB CO LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ODEON DDB CO LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 10 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Lee House 90 Great Bridgewater Street Manchester M1 5JW verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Lee House 90 Great Bridgewater Street Manchester M1 5JW geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX zum No 1 Colmore Square Birmingham B4 6HQ am 14. Dez. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Craig Ray Ramsey als Geschäftsführer am 06. Nov. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Brooks Rainer als Direktor am 06. Nov. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 02. Okt. 2017
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kirsten Lawton als Sekretär am 12. Juli 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Stephen Alker als Geschäftsführer am 06. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Jonathan Way als Geschäftsführer am 06. Juli 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Craig Ray Ramsey als Direktor am 06. Juli 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Michael Donovan als Geschäftsführer am 30. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ODEON DDB CO LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAINER, John Brooks | Geschäftsführer | Colmore Square B4 6HQ Birmingham No 1 | United States | American | Tax Acountant | 239691240001 | ||||
GAZDIG, Grant John Paul | Sekretär | 12 Ashburn House 35 Collingham Road SW5 0NU London | Canadian | Director | 78476440001 | |||||
GOSLING, Steven Paul | Sekretär | 5 Little Heath Lane Dunham Massey WA14 4TS Altrincham Cheshire | British | Director | 124301460001 | |||||
KACHINGWE, Mayamiko Allen Harrison | Sekretär | Flat 17 Buckland Crescent NW3 5DH London Greater London | British | Director | 99741450001 | |||||
LAWTON, Kirsten | Sekretär | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House | British | Chartered Secretary | 50045660003 | |||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 38508390004 | |||||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 38508390004 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Carmelite 50 Victoria Embankment Blackfriars EC4Y 0DX London | 84071220001 | |||||||
ALKER, Andrew Stephen | Geschäftsführer | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 120642230001 | ||||
CHADD, Andrew Peter | Geschäftsführer | The Old Pheasantry Woodcock Hill RH19 2RB Felbridge West Sussex | United Kingdom | British | Director | 133578890002 | ||||
CLUCAS, Neil Keith | Geschäftsführer | 43 Westcliffe Road PR8 2JS Southport Merseyside | Uk | British | Operations Director Odeon Uci | 108801550001 | ||||
DELLAL, Guy Sulman | Geschäftsführer | 1 Holland Park Avenue W11 3RH London | England | British | Director | 88802070001 | ||||
DONOVAN, Paul Michael | Geschäftsführer | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House England And Wales United Kingdom | England | British | Chief Executive | 154988050002 | ||||
GAVIN, Alexander Rupert, Sir | Geschäftsführer | Whitcomb Street WC2H 7DN London 54 | United Kingdom | British | Director | 16875680002 | ||||
GAZDIG, Grant John Paul | Geschäftsführer | 12 Ashburn House 35 Collingham Road SW5 0NU London | Canadian | Director | 78476440001 | |||||
GOSLING, Steven Paul | Geschäftsführer | 5 Little Heath Lane Dunham Massey WA14 4TS Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | Accountant | 124301460001 | ||||
GRAF VON SPONECK, Hans Alexander | Geschäftsführer | 7 Irving Road W14 0JT London | German Us | Banker | 88801930001 | |||||
GREEN, Nigel Graham | Geschäftsführer | 8 Bryman Court 31-32 Montagu Square W1H 2LH London | England | British | Director | 8499810001 | ||||
GREEN, Trevor Henry | Geschäftsführer | 7 Nottingham Terrace York Gate Regents Park NW1 4QB London | United Kingdom | British | Director | 8499820001 | ||||
HARRIS, Roger John | Geschäftsführer | Whitcomb Street WC2H 7DN London 54 | United Kingdom | British | Chief Operating Officer | 129109390001 | ||||
KACHINGWE, Mayamiko Allen Harrison | Geschäftsführer | Flat 17 Buckland Crescent NW3 5DH London Greater London | British | Director | 99741450001 | |||||
LANPHERE, Scott Allen | Geschäftsführer | Mayles 12 The Drive KT11 2JQ Cobham Surrey | United Kingdom | American | Director | 64952610002 | ||||
MALONE, Frank | Geschäftsführer | 14a Belgrave Court Canary Riverside 36 Westferry Circus E14 8RJ London | Irish | Banker | 95639090001 | |||||
MASON, Jonathan Peter | Geschäftsführer | Whitcomb Street WC2H 7DN London 54 | United Kingdom | British | Cfo Odeon Uci | 117783520001 | ||||
O'HAIRE, Cormac Patrick Thomas | Geschäftsführer | Sutherland Road Ealing W13 0DX London 17 | Irish | Finance Director | 89259830001 | |||||
PUNJA, Riaz | Geschäftsführer | Apartment 31 Albert Bridge House 127 Albert Bridge Road SW11 4PA London | United Kingdom | British | Director | 58870910002 | ||||
RAMSEY, Craig Ray | Geschäftsführer | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House | United States | American | Executive | 221321960001 | ||||
RAYMOND, Jonathan Joseph | Geschäftsführer | Flat 2 339 Portobello Road W10 5SA London | British | Financier | 75801880004 | |||||
RITVAY, Alexander Tibor Mihaly, Dr | Geschäftsführer | Mommsenstrasse 64 FOREIGN 10629 Berlin Germany | German | Lawyer | 95639320001 | |||||
SAUNDERS, Robin Elizabeth | Geschäftsführer | 1 Airlie Gardens W8 7AJ London | American | Director | 108076430001 | |||||
SEGAL, Richard Lawrence | Geschäftsführer | 16 Spencer Drive N2 0QX London | England | British | Managing Director | 47031800003 | ||||
TCHENGUIZ, Robert | Geschäftsführer | 6 Chesterfield Hill Mayfair W1J 5BL London | Iranian | Director | 74322720002 | |||||
WAIBL, Karin Elisabeth | Geschäftsführer | Niederkasseler Str. 83 FOREIGN 40547 Dusseldorf Germany | German | Banker Lawyer | 92888700001 | |||||
WAY, Mark Jonathan | Geschäftsführer | 57-59 Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 191239860001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ODEON DDB CO LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odeon Equity Co Limited | 06. Apr. 2016 | Haymarket SW1Y 4QX London St Albans House, 57 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ODEON DDB CO LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 24. Mai 2011 Geliefert am 07. Juni 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from odeon & uci bond midco limited or any restricted subsidiary to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Apr. 2007 Geliefert am 16. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right, title and interest from time to time in and to each of the following assets the material property other than the excluded property the tangible movable property the accounts the intellectual property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 03. Dez. 2004 Geliefert am 16. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and any obligor to the chargee (the security agent as agent and trustee for the secured parties), the loan note holder and any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The material property other than the excluded property; the tangible moveable property; the accounts; the intellectual property; any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company; the investments; the shares, all dividends, interest and other monies payable in respect of the shares and all other related rights; all monetary claims and all related rights; and any other contract or agreement to which the company is a party (other than the specific contracts) and all related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. Sept. 2004 Geliefert am 24. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 07. März 2003 Geliefert am 26. März 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities due or to become due from any obligor to the chargee as security trustee for the secured parties (the "security trustee") on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat ODEON DDB CO LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0