THC NM REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHC NM REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04677845
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von THC NM REALISATIONS LIMITED?

    • Betrieb von Sportanlagen (93110) / Kunst, Unterhaltung und Erholung

    Wo befindet sich THC NM REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Pearl Assurance House
    319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von THC NM REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TOPNOTCH HEALTH CLUBS (NEW MALDEN) LTD01. Aug. 200901. Aug. 2009
    VISION FITNESS (NEW MALDEN) LIMITED27. März 200327. März 2003
    SPEED 9528 LIMITED25. Feb. 200325. Feb. 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THC NM REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Apr. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für THC NM REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Mai 2018

    13 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE zum Pearl Assurance House 319 Ballards Lane London N12 8LY am 28. Juli 2021

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Mai 2021

    17 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Mai 2020

    13 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Mai 2019

    13 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Mai 2017

    13 SeitenLIQ03

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 28. Apr. 2016

    4 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Windsor Close West Cross Centre Brentford Middlesex TW8 9DZ zum 26-28 Bedford Row London WC1R 4HE am 03. Juni 2016

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 13. Mai 2016

    LRESEX

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name09. Apr. 2016

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 23. März 2016

    RES15

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 08. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 29. Apr. 2015

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. März 2015

    Kapitalaufstellung am 05. März 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen William Bradley am 05. März 2015

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 29. Apr. 2014

    9 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 25. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. März 2014

    Kapitalaufstellung am 24. März 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 29. Apr. 2013

    6 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Wer sind die Geschäftsführer von THC NM REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRADLEY, Stephen William
    319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House
    Geschäftsführer
    319 Ballards Lane
    N12 8LY London
    Pearl Assurance House
    EnglandBritish92354500001
    CRISP, David Adrian
    16 West Way
    Carshalton Beeches
    SM5 4EW Surrey
    Sekretär
    16 West Way
    Carshalton Beeches
    SM5 4EW Surrey
    British49416170003
    CRISP, David Adrian
    16 West Way
    Carshalton Beeches
    SM5 4EW Surrey
    Sekretär
    16 West Way
    Carshalton Beeches
    SM5 4EW Surrey
    British49416170003
    MAKWANA, Dipa Prakash
    Windsor Close
    West Cross Centre
    TW8 9DZ Brentford
    1
    Middlesex
    United Kingdom
    Sekretär
    Windsor Close
    West Cross Centre
    TW8 9DZ Brentford
    1
    Middlesex
    United Kingdom
    166138200001
    MAKWANA, Dipa Prakash
    Hollywood Gardens
    UB4 0DX Hayes
    44
    Middlesex
    Sekretär
    Hollywood Gardens
    UB4 0DX Hayes
    44
    Middlesex
    British107803140001
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    CRISP, David Adrian
    16 West Way
    Carshalton Beeches
    SM5 4EW Surrey
    Geschäftsführer
    16 West Way
    Carshalton Beeches
    SM5 4EW Surrey
    United KingdomBritish49416170003
    MACILWAINE, Gordon Michael
    Glenydd Penrallt Road
    Trearddur Bay Holyhead
    LL65 2UG Angelsey
    North Wales
    Geschäftsführer
    Glenydd Penrallt Road
    Trearddur Bay Holyhead
    LL65 2UG Angelsey
    North Wales
    British88872830001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Hat THC NM REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge
    Erstellt am 02. Okt. 2003
    Geliefert am 09. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/Hold property known as 23 blagdon rd,new malden,surrey KT3 4AH; SGL615040. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A charge
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 11. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as 23 blagdon road new malden surrey KT3 4AH t/n SGL615040. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 2003
    Geliefert am 15. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juni 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat THC NM REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Mai 2016Beginn der Liquidation
    30. Sept. 2022Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Mark Katz
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London
    Praktiker
    26-28 Bedford Row
    WC1R 4HE London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0