PROJECT LATERAL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePROJECT LATERAL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04684089
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PROJECT LATERAL LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich PROJECT LATERAL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Thames House, Portsmouth Road
    Esher
    KT10 9AD Surrey
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PROJECT LATERAL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BROOMCO (3136) LIMITED03. März 200303. März 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PROJECT LATERAL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PROJECT LATERAL LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für PROJECT LATERAL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Company business 09/06/2014
    RES13

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2013

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. März 2014

    Kapitalaufstellung am 06. März 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2011

    5 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2010

    5 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 03. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Steven Miles Smith am 02. März 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2009

    5 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2008

    5 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von PROJECT LATERAL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    REILLY, Michael Robert
    Rue De La Vielle Maze
    Castel
    GY5 7AT
    Lincluden
    Guernsey
    Channel Islands
    Sekretär
    Rue De La Vielle Maze
    Castel
    GY5 7AT
    Lincluden
    Guernsey
    Channel Islands
    British79103720004
    SMITH, Steven Miles
    Hawkesbury Braye Du Valle
    St Sampson
    GY2 4RB Guernsey
    Geschäftsführer
    Hawkesbury Braye Du Valle
    St Sampson
    GY2 4RB Guernsey
    GuernseyBritishDirector62484110002
    SMITH, Steven Miles
    Hawkesbury Braye Du Valle
    St Sampson
    GY2 4RB Guernsey
    Sekretär
    Hawkesbury Braye Du Valle
    St Sampson
    GY2 4RB Guernsey
    BritishCompany Director62484110002
    WILLIAMS, Richard Steven
    La Longue Maison
    Rue Des Bailleuls, St. Andrews
    GY6 8XB Guernsey
    Sekretär
    La Longue Maison
    Rue Des Bailleuls, St. Andrews
    GY6 8XB Guernsey
    BritishAccountant92144320002
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Sekretär
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    CANDY, Christian Peter
    Villa Hermose
    9 Boulevard De Suisse
    FOREIGN Monaco
    980000
    Monaco
    Geschäftsführer
    Villa Hermose
    9 Boulevard De Suisse
    FOREIGN Monaco
    980000
    Monaco
    BritishCompany Director87803790003
    CANDY, Nicholas Anthony Christopher
    Le Park Palace
    6 Impasse De La Fontaine
    Mc 98000
    Monaco
    Geschäftsführer
    Le Park Palace
    6 Impasse De La Fontaine
    Mc 98000
    Monaco
    BritishDirector92851350006
    SMITH, Steven Miles
    Hawkesbury Braye Du Valle
    St Sampson
    GY2 4RB Guernsey
    Geschäftsführer
    Hawkesbury Braye Du Valle
    St Sampson
    GY2 4RB Guernsey
    GuernseyBritishCompany Director62484110002
    WILLIAMS, Richard Steven
    Ru De La Masse
    GY5 7PJ Castel
    La Masse
    Guernsey
    Geschäftsführer
    Ru De La Masse
    GY5 7PJ Castel
    La Masse
    Guernsey
    GuernseyBritishAccountant92144320003
    WILLIAMS, Richard Steven
    La Longue Maison
    Rue Des Bailleuls, St. Andrews
    GY6 8XB Guernsey
    Geschäftsführer
    La Longue Maison
    Rue Des Bailleuls, St. Andrews
    GY6 8XB Guernsey
    Channel IslandsBritishAccountant92144320002
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    Hat PROJECT LATERAL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 06. Sept. 2004
    Geliefert am 16. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a and forming part of belgravia telephone exchange, 20-24 chesham place, belgravia, london t/n GBL41970 and f/h property k/a and forming part of belgravia telephone exchange, 20-24 chesham place, belgravia, london t/n LN36576. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 06. Sept. 2004
    Geliefert am 16. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment in security
    Erstellt am 06. Sept. 2004
    Geliefert am 16. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Rights, interests and benefits in and to the contract including without limitation the right to receive payments of principal and interest in respect of the contract.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment in security
    Erstellt am 06. Sept. 2004
    Geliefert am 16. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Rights, interests and benefits in and to the contract including without limitation the right to receive payments of principal and interest in respect of the contract. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0