FIFERS1 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FIFERS1 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04685088 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FIFERS1 LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich FIFERS1 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Lanmor House 370/386 High Road HA9 6AX Wembley Middlesex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FIFERS1 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für FIFERS1 LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für FIFERS1 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Ernennung von Mr Stuart John James Cruden Gray als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Neil Alan Quinsey am 01. Nov. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Neil Alan Quinsey als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Lanmor House High Road Wembley Middlesex HA9 6AX United Kingdom* am 04. Okt. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Malcolm Robson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2013 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Verschiedenes Auditors resignation | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Cedar House 105 Carrow Road Norwich Norfolk NR1 1HP* am 15. März 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2012 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 9 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 11 Seiten | MG01 | ||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 54 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FIFERS1 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUINSEY, Neil Alan | Sekretär | 370/386 High Road HA9 6AX Wembley Lanmor House Middlesex England | British | 139110160001 | ||||||
| GRAY, Stuart John James Cruden | Geschäftsführer | 370/386 High Road HA9 6AX Wembley Lanmor House Middlesex | England | British | 186885670001 | |||||
| HARRISON, Thomas Frederick Teviot | Geschäftsführer | 370/386 High Road HA9 6AX Wembley Lanmor House Middlesex England | United Kingdom | British | 81581440001 | |||||
| QUINSEY, Neil Alan | Geschäftsführer | 370/386 High Road HA9 6AX Wembley Lanmor House Middlesex England | England | British | 184919650001 | |||||
| ELLIS, Linda Denise | Sekretär | 55 Keswick Road Cringleford NR4 6UQ Norwich Norfolk | British | 40350070002 | ||||||
| ROBSON, Malcolm Henry | Sekretär | 65 Bury Street NR2 2DL Norwich Norfolk | British | 6205710001 | ||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 69 Southampton Row WC1B 4ET London Marquess Court | 900027310001 | |||||||
| NORTON, Nicholas George | Geschäftsführer | Grove Cottage Frettenham Road Hainford NR10 3BW Norwich | England | British | 45082110002 | |||||
| ROBSON, Malcolm Henry | Geschäftsführer | High Road HA9 6AX Wembley Lanmor House Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 6205710001 | |||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 69 Southampton Row WC1B 4ET London Marquess Court | 900027300001 |
Hat FIFERS1 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 30. Sept. 2011 Geliefert am 06. Okt. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any obligor to any secured party on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land on the north side of new close lane ducklington lane t/no ON241130 and f/h land on the west side of ducklington lane witney t/no ON153880 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) thereon all other interest in any f/h or l/h property all proceeds of sale the benefit of all warranties and covenants and all licences rental income and occupational leases see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Aug. 2011 Geliefert am 02. Sept. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor or any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Nov. 2007 Geliefert am 23. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land k/a land on the north side of new close lane ducklington lane witney t/no ON241130 and f/h land k/a the land on the west side of ducklington lane witne. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Apr. 2003 Geliefert am 26. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0