HAWARDEN BUSINESS PARK LIMITED

HAWARDEN BUSINESS PARK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHAWARDEN BUSINESS PARK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04696878
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HAWARDEN BUSINESS PARK LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich HAWARDEN BUSINESS PARK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HAWARDEN BUSINESS PARK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INTERCITY (HAWARDEN) LIMITED04. Juli 200304. Juli 2003
    HAMSARD 2642 LIMITED13. März 200313. März 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HAWARDEN BUSINESS PARK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Feb. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für HAWARDEN BUSINESS PARK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    23 SeitenAM23

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    26 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    28 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    29 SeitenAM10

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA

    11 SeitenAM02

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    3 SeitenAM06

    Vorschlag des Verwalters

    35 SeitenAM03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Pochin's Limited Brooks Lane Middlewich Cheshire CW10 0JQ zum 4 Hardman Square Manchester M3 3EB am 27. Aug. 2019

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    3 SeitenAM01

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2018

    18 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2017

    18 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Feb. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2016

    18 SeitenAA

    Ernennung von Mr Nigel Keith Rawlings als Sekretär am 31. Aug. 2016

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Daniel Manus Adamson als Sekretär am 31. Aug. 2016

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Daniel Manus Adamson als Sekretär am 11. Juli 2016

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Nigel Keith Rawlings als Sekretär am 11. Juli 2016

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Feb. 2016

    Kapitalaufstellung am 23. Feb. 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2015

    17 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr James William Pochin Nicholson am 01. Mai 2015

    2 SeitenCH01

    Wer sind die Geschäftsführer von HAWARDEN BUSINESS PARK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    RAWLINGS, Nigel Keith
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Sekretär
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    213660100001
    NICHOLSON, James William Pochin
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Geschäftsführer
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomBritishDirector36885270002
    NICHOLSON, Robert Kenneth Heywood
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Geschäftsführer
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomBritishDirector36885710002
    ADAMSON, Daniel Manus
    Brooks Lane
    CW10 0JQ Middlewich
    Pochin's Limited
    Cheshire
    Sekretär
    Brooks Lane
    CW10 0JQ Middlewich
    Pochin's Limited
    Cheshire
    210548200001
    AMBROSE, Lynne
    46 Riding Hill Road
    Knowsley Village
    L34 0EG Liverpool
    Merseyside
    Sekretär
    46 Riding Hill Road
    Knowsley Village
    L34 0EG Liverpool
    Merseyside
    British96746390001
    BUCHANAN, Andrea
    Laurel Grange 33 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DN Warrington
    Cheshire
    Sekretär
    Laurel Grange 33 Stonyhurst Crescent
    Culcheth
    WA3 4DN Warrington
    Cheshire
    BritishChartered Accountant115545000002
    HEDLEY, David James
    Brooks Lane
    CW10 0JQ Middlewich
    Pochin's Plc
    Cheshire
    England
    Sekretär
    Brooks Lane
    CW10 0JQ Middlewich
    Pochin's Plc
    Cheshire
    England
    British108549300001
    RAWLINGS, Nigel Keith
    Brooks Lane
    CW10 0JQ Middlewich
    Pochin's Limited
    Cheshire
    England
    Sekretär
    Brooks Lane
    CW10 0JQ Middlewich
    Pochin's Limited
    Cheshire
    England
    183415590001
    SHAW, David
    9 Gorsty Hill Close
    Balterley Heath
    CW2 5QS Crewe
    Cheshire
    Sekretär
    9 Gorsty Hill Close
    Balterley Heath
    CW2 5QS Crewe
    Cheshire
    British36482830002
    WAUGH, Andrew Arthur
    9 Midge Hall Drive
    OL11 4AX Bamford
    Rochdale
    Sekretär
    9 Midge Hall Drive
    OL11 4AX Bamford
    Rochdale
    British163663950001
    HAMMONDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Bevollmächtigter Sekretär
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    900026750001
    PARKER, Simon Gary, Mr.
    Churton Lodge
    Chester Road Churton
    CH3 6LA Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Churton Lodge
    Chester Road Churton
    CH3 6LA Chester
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director76749130002
    SHAOUL, Joseph Michael
    20 Hazelmere Avenue
    Hale Barns
    WA15 0AU Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    20 Hazelmere Avenue
    Hale Barns
    WA15 0AU Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director20145240001
    WOODCOCK, John Hamilton
    Davenport Barn Davenport Park Lane
    Holmes Chapel Road
    CW12 4ST Holmes Chapel
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Davenport Barn Davenport Park Lane
    Holmes Chapel Road
    CW12 4ST Holmes Chapel
    Cheshire
    EnglandBritishDirector20897510002
    HAMMONDS DIRECTORS LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    900026740001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HAWARDEN BUSINESS PARK LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Pochin's Limited
    Brooks Lane
    CW10 0JQ Middlewich
    Pochin's Limited
    England
    01. Juni 2016
    Brooks Lane
    CW10 0JQ Middlewich
    Pochin's Limited
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUk Companies Act
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer00300573
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat HAWARDEN BUSINESS PARK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 16. Juli 2014
    Geliefert am 17. Juli 2014
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 05. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H plots 3 and 4 hawarden industrial estate. Any goodwill, fixed charge, all plant, machinery and other items attached. Floating charge all unattached plant, machinery, chattels and goods see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 07. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H land k/a plots 3 and 4 hawarden business park manor lane hawarden flintshire.
    Berechtigte Personen
    • The Welsh Ministers
    Transaktionen
    • 07. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 07. März 2008
    Geliefert am 26. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H land k/a plots 3 and 4 hawarden business park manor lane hawarden flintshire t/no WA910439 together with the buildings, fixtures see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Welsh Ministers
    Transaktionen
    • 26. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 07. März 2008
    Geliefert am 12. März 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings k/a units 3 and 4 hawarden business park manor lane hawarden flintshire t/no WA910439 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Jan. 2007
    Geliefert am 13. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Plot 9 hawarden business park manor lane hawarden flintshire.
    Berechtigte Personen
    • The National Assembly for Wales
    Transaktionen
    • 13. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 23. Jan. 2007
    Geliefert am 01. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All sums (in whatever currency) together with all interest and other amounts accruing on them for the time being standing to the credit of the charged account (as defined in the charge over cash deposit) which account is blocked or designated as charged to the bank.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Jan. 2007
    Geliefert am 01. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Property k/a unit 9 hawarden business park, manor lane, hawarden, flintshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Nov. 2005
    Geliefert am 07. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Land and buildings lying to the east of third avenue hawarden industrial estate t/no wa 659559. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 22. März 2004
    Geliefert am 27. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juni 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 22. März 2004
    Geliefert am 27. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h premises k/a units 7/8 hawarden business park manor lane lawarden flintshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over shares
    Erstellt am 22. März 2004
    Geliefert am 27. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the securities and their proceeds of sale all dividends interest and other distributions all accretions rights benefits money or property accruing issued or offered in respect of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. März 2004Registrierung einer Belastung (395)

    Hat HAWARDEN BUSINESS PARK LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    05. Aug. 2019Beginn der Verwaltung
    16. Aug. 2021Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Sarah O'Toole
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Praktiker
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Jason Bell
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Praktiker
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0