LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04707146 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Linpac Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract West Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HACKREMCO (NO. 2045) LIMITED | 21. März 2003 | 21. März 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 047071460008 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 047071460007 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 08. Sept. 2023
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 28 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. März 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. März 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Eintragung der Belastung 047071460008, erstellt am 20. Sept. 2021 | 10 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 10. Aug. 2021
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roxane Manuela Tamas als Sekretär am 18. Juni 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. März 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Cessation of Victor Khosla as a person with significant control on 27. Mai 2016 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||||||
Notification of Linpac Group Holdings Ltd as a person with significant control on 27. Mai 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Alfred Jones als Geschäftsführer am 08. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
Eintragung der Belastung 047071460007, erstellt am 28. Apr. 2020 | 8 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. März 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARNETT, Adam Richard | Geschäftsführer | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire | England | British | 154433520001 | |||||
| FENSOME, Richard James | Sekretär | Ravenscroft 15 Fulmer Drive SL9 7HH Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 84096960001 | ||||||
| JOSEPH, Simon Elliot | Sekretär | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire England | British | 113862500001 | ||||||
| LENCE, Robert Burton | Sekretär | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire | 242529020001 | |||||||
| TAMAS, Roxane Manuela, Ms. | Sekretär | Kingdom Street W2 6BD London 4 England | 264218020001 | |||||||
| HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||
| ALLKINS, John Stephen | Geschäftsführer | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire England | England | British | 94637290001 | |||||
| ARROWSMITH, Michael Richard | Geschäftsführer | 3180 Park Square Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham | England | British | 64948610002 | |||||
| CARR, Nigel Edmund | Geschäftsführer | 3180 Park Square Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham | United Kingdom | British | 146677560001 | |||||
| DARLINGTON, John | Geschäftsführer | 3180 Park Square Birmingham Business Park B37 7YN Birmingham | United Kingdom | British | 63191200003 | |||||
| DAYAN, Daniel Alexander | Geschäftsführer | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire | England | British | 114867990002 | |||||
| DURSTON, John | Geschäftsführer | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire England | United Kingdom | British | 156838680001 | |||||
| JONES, John Alfred, Mr. | Geschäftsführer | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire | England | British | 67483720001 | |||||
| JOSEPH, Simon Elliot | Geschäftsführer | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire England | United Kingdom | British | 113862500001 | |||||
| LANG, Robert Alexander | Geschäftsführer | 6360 River Overlook Drive FOREIGN Atlanta Ga30328 Georgia Usa | British | 102537350001 | ||||||
| MELDRAM, David | Geschäftsführer | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire England | England | British | 80950780002 | |||||
| NICHOLLS, Michael Philip | Geschäftsführer | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire England | United Kingdom | British | 133570750001 | |||||
| PAUL, Richard Neil | Geschäftsführer | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire England | England | British | 43099210003 | |||||
| RAY, Stephen Douglas | Geschäftsführer | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire England | England | British | 147866070001 | |||||
| SHANLEY, Patrick | Geschäftsführer | Stratford Road Wootton Wawen B95 6AP Henley-In-Arden Clover Bank House West Midlands | England | British | 130362780001 | |||||
| TENTORI, Mark Ian | Geschäftsführer | Holly Hedges Tingrith Road Evershot MK17 9EF Milton Keynes Buckinghamshire | England | British | 119564310001 | |||||
| WILLIAMS, David Arthur | Geschäftsführer | 9 The Crescent Hartford CW8 1QS Northwich Cheshire | United Kingdom | British | 16979530001 | |||||
| HACKWOOD DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004840001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linpac Group Holdings Ltd | 27. Mai 2016 | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Wakefield Road England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Mr Victor Khosla | 06. Apr. 2016 | Wakefield Road Featherstone WF7 5DE Pontefract Linpac West Yorkshire | Ja | ||||||||||
Nationalität: American Staatsangehörigkeit: United States | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 20. Sept. 2021 Geliefert am 21. Sept. 2021 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 28. Apr. 2020 Geliefert am 18. Mai 2020 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 08. Juli 2016 Geliefert am 08. Juli 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 12. Sept. 2012 Geliefert am 20. Sept. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 25 september 2003 and | Erstellt am 31. Aug. 2011 Geliefert am 16. Sept. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Dez. 2009 Geliefert am 23. Dez. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A pledge agreement | Erstellt am 22. Aug. 2003 Geliefert am 08. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as hackremco (no.2045) limited to the senior beneficiaries and the mezzanine beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben A special financial instruments account no.1 Bis (the pledged account) opened in the books of picnal france, a french societe par actions simplifiee with a share capital of eur 37,000 whose registered office is at 1, rue favart 75002 paris france registred with the trade registry of paris under number 449 703 941 (the account holder) in which are registred 37,000 shares of the account holder representing 100% of the share capital of the account holder (the shares). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Aug. 2003 Geliefert am 08. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly known as hackremco (no.2045) limited and any other obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0