KBC BOURNEMOUTH LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKBC BOURNEMOUTH LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04710659
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KBC BOURNEMOUTH LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich KBC BOURNEMOUTH LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    268 Bath Road
    SL1 4DX Slough
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von KBC BOURNEMOUTH LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    KINGSHOTT BUSINESS CENTRES LIMITED25. März 200325. März 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KBC BOURNEMOUTH LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für KBC BOURNEMOUTH LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für KBC BOURNEMOUTH LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Jahresrückblick erstellt bis 25. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 09. Juni 2015

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Beendigung der Bestellung eines Geschäftsführers

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Peter David Edward Gibson als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Richard Morris als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Paul Andrew Alexander als Geschäftsführer am 31. Mai 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Peter David Edward Gibson als Direktor am 10. Apr. 2015

    AP01

    Ernennung von Mr Richard Morris als Direktor am 10. Apr. 2015

    AP01

    Beendigung der Bestellung von Marie Elizabeth Edwards als Sekretär am 10. Apr. 2015

    TM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Lyric Square London W6 0NB England zum 268 Bath Road Slough SL1 4DX am 22. Apr. 2015

    AD01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    17 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Michael James Kingshott als Geschäftsführer am 12. Feb. 2015

    TM01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 06. Feb. 2015

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 22. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    2 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von KBC BOURNEMOUTH LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GIBSON, Peter David Edward
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Geschäftsführer
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Northern IrelandBritish139640170001
    MORRIS, Richard
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Geschäftsführer
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish190653350001
    PEPPER, Alan Douglas
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Geschäftsführer
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish98245120002
    ALEXANDER, Paul
    c/o C/O Serviced Office Group
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    Sekretär
    c/o C/O Serviced Office Group
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    England
    183163770001
    CLAGUE, Stephen James Taylor
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    Sekretär
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    British73690140002
    CORT, Louise
    7a Ellerton Road
    Earlsfield
    SW18 3NG London
    Sekretär
    7a Ellerton Road
    Earlsfield
    SW18 3NG London
    British84863600003
    EDWARDS, Marie Elizabeth
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Sekretär
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    185429330001
    SAVANI, Iqbal
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    Sekretär
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    British96895020001
    SCANNELL, Elizabeth Jane
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    United Kingdom
    Sekretär
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    United Kingdom
    150677530002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    Bevollmächtigter Sekretär
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    900027310001
    ALEXANDER, Paul Andrew
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    Geschäftsführer
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    268
    England
    EnglandBritish97550550001
    CLAGUE, Stephen James Taylor
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    Geschäftsführer
    72 Shinfield Road
    RG2 7DA Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish73690140002
    CORT, Louise
    7a Ellerton Road
    Earlsfield
    SW18 3NG London
    Geschäftsführer
    7a Ellerton Road
    Earlsfield
    SW18 3NG London
    British84863600003
    KINGSHOTT, Michael James
    Long Acre
    WC2E 1LY London
    22
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Long Acre
    WC2E 1LY London
    22
    United Kingdom
    EnglandBritish83713020002
    SAVANI, Iqbal
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    18 Berry Hill
    HA7 4XS Stanmore
    Middlesex
    British96895020001
    SCANNELL, Elizabeth Jane
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Long Acre
    WC2E 9LY London
    22
    United Kingdom
    EnglandBritish154659960001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    69 Southampton Row
    WC1B 4ET London
    Marquess Court
    900027300001

    Hat KBC BOURNEMOUTH LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 22. Nov. 2012
    Geliefert am 29. Nov. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Premier house, hinton road, dorset t/no DT252227. By way of fixed charge all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land, the proceeds of sale of the property, the benefit of any rental deposit all rents and other sums due under any lease, all plant and machinery and the benefit of all contracts, licences and warranties and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 22. Nov. 2012
    Geliefert am 29. Nov. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Premier house, hinton road, dorset t/no DT252227 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Nov. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Nov. 2012
    Geliefert am 28. Nov. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Kbc kingston limited, f/h 12-50 kingsgate road, kingston t/no SY279853, SY327216, SY254907, SGL124369 and SGL58811, kbc hayes limited, f/h 23 clayton road, hayes t/no AGL2697 and kbc harrow limited, f/h 2 gayton road, harrow t/no NGL571767 together with all rents receivable, all the goodwill, all fixtures and fittings, all plant and machinery see image for full details. For further details of properties charged please see form MG01.
    Berechtigte Personen
    • West Register Number 2 Limited
    Transaktionen
    • 28. Nov. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Dez. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Okt. 2004
    Geliefert am 02. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a premier house,hinton,bournemouth t/no DT252227. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 21. Okt. 2004
    Geliefert am 28. Okt. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 02. Apr. 2003
    Geliefert am 09. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Apr. 2003
    Geliefert am 09. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as premier house 23 hinton road bournemouth. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Okt. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0