KBC BOURNEMOUTH LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | KBC BOURNEMOUTH LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04710659 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KBC BOURNEMOUTH LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich KBC BOURNEMOUTH LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 268 Bath Road SL1 4DX Slough |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KBC BOURNEMOUTH LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| KINGSHOTT BUSINESS CENTRES LIMITED | 25. März 2003 | 25. März 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KBC BOURNEMOUTH LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für KBC BOURNEMOUTH LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für KBC BOURNEMOUTH LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 25. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung eines Geschäftsführers | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Peter David Edward Gibson als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Morris als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Andrew Alexander als Geschäftsführer am 31. Mai 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Peter David Edward Gibson als Direktor am 10. Apr. 2015 | AP01 | |||||||||||
Ernennung von Mr Richard Morris als Direktor am 10. Apr. 2015 | AP01 | |||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marie Elizabeth Edwards als Sekretär am 10. Apr. 2015 | TM02 | |||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Lyric Square London W6 0NB England zum 268 Bath Road Slough SL1 4DX am 22. Apr. 2015 | AD01 | |||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael James Kingshott als Geschäftsführer am 12. Feb. 2015 | TM01 | |||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 06. Feb. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 22. Dez. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von KBC BOURNEMOUTH LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIBSON, Peter David Edward | Geschäftsführer | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | Northern Ireland | British | 139640170001 | |||||
| MORRIS, Richard | Geschäftsführer | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | England | British | 190653350001 | |||||
| PEPPER, Alan Douglas | Geschäftsführer | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | England | British | 98245120002 | |||||
| ALEXANDER, Paul | Sekretär | c/o C/O Serviced Office Group Long Acre WC2E 9LY London 22 England | 183163770001 | |||||||
| CLAGUE, Stephen James Taylor | Sekretär | 72 Shinfield Road RG2 7DA Reading Berkshire | British | 73690140002 | ||||||
| CORT, Louise | Sekretär | 7a Ellerton Road Earlsfield SW18 3NG London | British | 84863600003 | ||||||
| EDWARDS, Marie Elizabeth | Sekretär | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | 185429330001 | |||||||
| SAVANI, Iqbal | Sekretär | 18 Berry Hill HA7 4XS Stanmore Middlesex | British | 96895020001 | ||||||
| SCANNELL, Elizabeth Jane | Sekretär | Long Acre WC2E 9LY London 22 United Kingdom | 150677530002 | |||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 69 Southampton Row WC1B 4ET London Marquess Court | 900027310001 | |||||||
| ALEXANDER, Paul Andrew | Geschäftsführer | Bath Road SL1 4DX Slough 268 England | England | British | 97550550001 | |||||
| CLAGUE, Stephen James Taylor | Geschäftsführer | 72 Shinfield Road RG2 7DA Reading Berkshire | United Kingdom | British | 73690140002 | |||||
| CORT, Louise | Geschäftsführer | 7a Ellerton Road Earlsfield SW18 3NG London | British | 84863600003 | ||||||
| KINGSHOTT, Michael James | Geschäftsführer | Long Acre WC2E 1LY London 22 United Kingdom | England | British | 83713020002 | |||||
| SAVANI, Iqbal | Geschäftsführer | 18 Berry Hill HA7 4XS Stanmore Middlesex | British | 96895020001 | ||||||
| SCANNELL, Elizabeth Jane | Geschäftsführer | Long Acre WC2E 9LY London 22 United Kingdom | England | British | 154659960001 | |||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 69 Southampton Row WC1B 4ET London Marquess Court | 900027300001 |
Hat KBC BOURNEMOUTH LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 22. Nov. 2012 Geliefert am 29. Nov. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Premier house, hinton road, dorset t/no DT252227. By way of fixed charge all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land, the proceeds of sale of the property, the benefit of any rental deposit all rents and other sums due under any lease, all plant and machinery and the benefit of all contracts, licences and warranties and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Nov. 2012 Geliefert am 29. Nov. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Premier house, hinton road, dorset t/no DT252227 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Nov. 2012 Geliefert am 28. Nov. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Kbc kingston limited, f/h 12-50 kingsgate road, kingston t/no SY279853, SY327216, SY254907, SGL124369 and SGL58811, kbc hayes limited, f/h 23 clayton road, hayes t/no AGL2697 and kbc harrow limited, f/h 2 gayton road, harrow t/no NGL571767 together with all rents receivable, all the goodwill, all fixtures and fittings, all plant and machinery see image for full details. For further details of properties charged please see form MG01. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Okt. 2004 Geliefert am 02. Nov. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a premier house,hinton,bournemouth t/no DT252227. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Okt. 2004 Geliefert am 28. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Apr. 2003 Geliefert am 09. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 02. Apr. 2003 Geliefert am 09. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property known as premier house 23 hinton road bournemouth. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0