RAISEWATER LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | RAISEWATER LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04717167 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RAISEWATER LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich RAISEWATER LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 48a High Street HA8 7EQ Edgeware Middlesex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RAISEWATER LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 05. Apr. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für RAISEWATER LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für RAISEWATER LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 2 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Russell als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Lewin als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von First Names Secretaries (Isle of Man) Limited als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Apr. 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ifg International (Secretaries) Limited am 01. Feb. 2013 | 3 Seiten | CH04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Apr. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Apr. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 48a High Street Edgware Middlesex HA8 7EQ* am 19. Apr. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ifg International (Secretaries) Limited am 31. März 2011 | 2 Seiten | CH04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für James Edmund Russell am 31. März 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr. Mark Jonathan Lewin am 31. März 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 05. Apr. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Aprirose House 48 High Street Edgware Middlesex HA8 7EQ* am 03. Juni 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 15 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für James Edmund Russell am 03. Mai 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Ifg International (Secretaries) Limited als Sekretär | 3 Seiten | AP04 | ||||||||||
Ernennung von Mark Jonathan Lewin als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von James Edmund Russell als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RAISEWATER LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUDKA, Manish Mansukhlal | Sekretär | 10 Parkside Mill Hill NW7 2LH London | British | 57254710001 | ||||||||||||||
| LEWIN, Mark Jonathan | Sekretär | Ballacowle Bungalow Agneash IM4 7NP Lonan Isle Of Man | British | 150917780001 | ||||||||||||||
| CHURCH STREET NOMINEES LIMITED | Sekretär | St George's Court Upper Church Street IM1 1EE Douglas Isle Of Man Isle Ofman | 112883660001 | |||||||||||||||
| FIRST NAMES SECRETARIES (ISLE OF MAN) LIMITED | Sekretär | Castle Hill Victoria Road IM2 4RB Douglas International House Isle Of Man |
| 203287500001 | ||||||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||||||
| CAMPBELL, Mary Edel Gabrielle | Geschäftsführer | 124 Fairways Drive IM4 2JB Mount Murray Santon Isle Of Man | Isle Of Man | British | 126356440001 | |||||||||||||
| CAMPBELL, Mary Edel Gabrielle | Geschäftsführer | 124 Fairways Drive IM4 2JB Mount Murray Santon Isle Of Man | Isle Of Man | British | 126356440001 | |||||||||||||
| CARTY, Jane Elicia | Geschäftsführer | 5 Wallberry Mews Farmhill IM2 2ND Douglas Isle Of Man | British | 89989340001 | ||||||||||||||
| CLAGUE, Steven | Geschäftsführer | 24 Bowness Crescent IM3 2DH Onchan Isle Of Man | British | 118858560001 | ||||||||||||||
| CORLETT, Mark Richard | Geschäftsführer | Greenbank Bride Road IM8 3UN Ramsey Isle Of Man | British | 114060670001 | ||||||||||||||
| DENT, Victoria Kim | Geschäftsführer | 35 Ashberry Avenue Saddlestone IM2 1PY Braddan Isle Of Man | Isle Of Man | British | 171530280001 | |||||||||||||
| DIVALL, Stuart David | Geschäftsführer | Ballavitchel Road Crosby IM4 2DL Isle Of Man Borswood | Isle Of Man | British | 133597360001 | |||||||||||||
| GIBSON, Stuart Marcus | Geschäftsführer | 124 Fairways Drive Mount Murray IM4 2JB Santon Isle Of Man | British | 116795450001 | ||||||||||||||
| GIBSON, Stuart Marcus | Geschäftsführer | 12 Wentworth Close Howstrake Heights IM3 2JU Onchan Isle Of Man | Isle Of Man | British | 116794790001 | |||||||||||||
| GUDKA, Manish Mansukhlal | Geschäftsführer | 10 Parkside Mill Hill NW7 2LH London | United Kingdom | British | 57254710001 | |||||||||||||
| LEWIN, Mark Jonathan | Geschäftsführer | c/o Ifg International Limited Castle Hill Victoria Road IM2 4RB Douglas International House Isle Of Man | Isle Of Man | British | 150917780001 | |||||||||||||
| RUSSELL, James Edmund | Geschäftsführer | c/o Ifg International Limited Castle Hill Victoria Road IM2 4RB Douglas International House Isle Of Man | Isle Of Man | British | 150562410002 | |||||||||||||
| VENEIK, Vinay | Geschäftsführer | 4 Woodview Close Kingston Vale SW15 3RL London | British | 52547130001 | ||||||||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat RAISEWATER LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 10. Feb. 2006 Geliefert am 28. Feb. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Feb. 2006 Geliefert am 28. Feb. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land k/a land on the east side of dickson road blackpool t/n LA937318. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Juni 2003 Geliefert am 04. Juli 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Juni 2003 Geliefert am 04. Juli 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or streamzest limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold property known as land and buildings on the south side moor house street and land and buildings on the east side of dickson road blackpool lancashire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge | Erstellt am 15. Apr. 2003 Geliefert am 30. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from lionsgate properties (no 1) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h land being land and buildings on the east side of dickson road blackpool, on the south side of moor house street blackpool t/n la 465599 and LA470783 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same. Fixed charge on all moneys deposited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0