RAISEWATER LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRAISEWATER LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04717167
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RAISEWATER LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich RAISEWATER LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    48a High Street
    HA8 7EQ Edgeware
    Middlesex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RAISEWATER LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis05. Apr. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für RAISEWATER LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für RAISEWATER LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    2 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital31. März 2014

    Kapitalaufstellung am 31. März 2014

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Beendigung der Bestellung von James Russell als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Lewin als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von First Names Secretaries (Isle of Man) Limited als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Apr. 2013

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Ifg International (Secretaries) Limited am 01. Feb. 2013

    3 SeitenCH04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Apr. 2012

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 05. Apr. 2011

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 48a High Street Edgware Middlesex HA8 7EQ* am 19. Apr. 2011

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Sekretärs für Ifg International (Secretaries) Limited am 31. März 2011

    2 SeitenCH04

    Änderung der Details des Direktors für James Edmund Russell am 31. März 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr. Mark Jonathan Lewin am 31. März 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 05. Apr. 2010

    6 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Aprirose House 48 High Street Edgware Middlesex HA8 7EQ* am 03. Juni 2010

    2 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    15 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für James Edmund Russell am 03. Mai 2010

    3 SeitenCH01

    Ernennung von Ifg International (Secretaries) Limited als Sekretär

    3 SeitenAP04

    Ernennung von Mark Jonathan Lewin als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von James Edmund Russell als Direktor

    3 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von RAISEWATER LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GUDKA, Manish Mansukhlal
    10 Parkside
    Mill Hill
    NW7 2LH London
    Sekretär
    10 Parkside
    Mill Hill
    NW7 2LH London
    British57254710001
    LEWIN, Mark Jonathan
    Ballacowle Bungalow
    Agneash
    IM4 7NP Lonan
    Isle Of Man
    Sekretär
    Ballacowle Bungalow
    Agneash
    IM4 7NP Lonan
    Isle Of Man
    British150917780001
    CHURCH STREET NOMINEES LIMITED
    St George's Court
    Upper Church Street
    IM1 1EE Douglas
    Isle Of Man
    Isle Ofman
    Sekretär
    St George's Court
    Upper Church Street
    IM1 1EE Douglas
    Isle Of Man
    Isle Ofman
    112883660001
    FIRST NAMES SECRETARIES (ISLE OF MAN) LIMITED
    Castle Hill
    Victoria Road
    IM2 4RB Douglas
    International House
    Isle Of Man
    Sekretär
    Castle Hill
    Victoria Road
    IM2 4RB Douglas
    International House
    Isle Of Man
    RechtsformPRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
    Art des AusweisesNicht-EWR
    RechtsgrundlageISLE OF MAN
    Registrierungsnummer28391C
    203287500001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CAMPBELL, Mary Edel Gabrielle
    124 Fairways Drive
    IM4 2JB Mount Murray Santon
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    124 Fairways Drive
    IM4 2JB Mount Murray Santon
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish126356440001
    CAMPBELL, Mary Edel Gabrielle
    124 Fairways Drive
    IM4 2JB Mount Murray Santon
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    124 Fairways Drive
    IM4 2JB Mount Murray Santon
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish126356440001
    CARTY, Jane Elicia
    5 Wallberry Mews
    Farmhill
    IM2 2ND Douglas
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    5 Wallberry Mews
    Farmhill
    IM2 2ND Douglas
    Isle Of Man
    British89989340001
    CLAGUE, Steven
    24 Bowness Crescent
    IM3 2DH Onchan
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    24 Bowness Crescent
    IM3 2DH Onchan
    Isle Of Man
    British118858560001
    CORLETT, Mark Richard
    Greenbank
    Bride Road
    IM8 3UN Ramsey
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    Greenbank
    Bride Road
    IM8 3UN Ramsey
    Isle Of Man
    British114060670001
    DENT, Victoria Kim
    35 Ashberry Avenue
    Saddlestone
    IM2 1PY Braddan
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    35 Ashberry Avenue
    Saddlestone
    IM2 1PY Braddan
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish171530280001
    DIVALL, Stuart David
    Ballavitchel Road
    Crosby
    IM4 2DL Isle Of Man
    Borswood
    Geschäftsführer
    Ballavitchel Road
    Crosby
    IM4 2DL Isle Of Man
    Borswood
    Isle Of ManBritish133597360001
    GIBSON, Stuart Marcus
    124 Fairways Drive
    Mount Murray
    IM4 2JB Santon
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    124 Fairways Drive
    Mount Murray
    IM4 2JB Santon
    Isle Of Man
    British116795450001
    GIBSON, Stuart Marcus
    12 Wentworth Close
    Howstrake Heights
    IM3 2JU Onchan
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    12 Wentworth Close
    Howstrake Heights
    IM3 2JU Onchan
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish116794790001
    GUDKA, Manish Mansukhlal
    10 Parkside
    Mill Hill
    NW7 2LH London
    Geschäftsführer
    10 Parkside
    Mill Hill
    NW7 2LH London
    United KingdomBritish57254710001
    LEWIN, Mark Jonathan
    c/o Ifg International Limited
    Castle Hill
    Victoria Road
    IM2 4RB Douglas
    International House
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    c/o Ifg International Limited
    Castle Hill
    Victoria Road
    IM2 4RB Douglas
    International House
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish150917780001
    RUSSELL, James Edmund
    c/o Ifg International Limited
    Castle Hill
    Victoria Road
    IM2 4RB Douglas
    International House
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    c/o Ifg International Limited
    Castle Hill
    Victoria Road
    IM2 4RB Douglas
    International House
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish150562410002
    VENEIK, Vinay
    4 Woodview Close
    Kingston Vale
    SW15 3RL London
    Geschäftsführer
    4 Woodview Close
    Kingston Vale
    SW15 3RL London
    British52547130001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat RAISEWATER LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 10. Feb. 2006
    Geliefert am 28. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Feb. 2006
    Geliefert am 28. Feb. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land k/a land on the east side of dickson road blackpool t/n LA937318. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nationwide Building Society
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juni 2003
    Geliefert am 04. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 2003
    Geliefert am 04. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or streamzest limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold property known as land and buildings on the south side moor house street and land and buildings on the east side of dickson road blackpool lancashire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 15. Apr. 2003
    Geliefert am 30. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from lionsgate properties (no 1) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h land being land and buildings on the east side of dickson road blackpool, on the south side of moor house street blackpool t/n la 465599 and LA470783 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same. Fixed charge on all moneys deposited.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transaktionen
    • 30. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0