LEVANTINE 2003 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLEVANTINE 2003 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04724413
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LEVANTINE 2003 LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich LEVANTINE 2003 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    9 Park View
    Greyfriars Road
    CF10 3AL Cardiff
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEVANTINE 2003 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für LEVANTINE 2003 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Apr. 2010

    Kapitalaufstellung am 29. Apr. 2010

    • Kapital: GBP 750
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Paramount Secretaries Ltd am 06. Apr. 2010

    2 SeitenCH04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2009

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Steven Williams als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2008

    3 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2007

    5 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten169

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Mai 2006

    9 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    8 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    7 SeitenAA

    legacy

    9 Seiten363s

    legacy

    3 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von LEVANTINE 2003 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PARAMOUNT SECRETARIES LTD
    Gold Tops
    NP20 4PG Newport
    Summit House
    Gwent
    United Kingdom
    Sekretär
    Gold Tops
    NP20 4PG Newport
    Summit House
    Gwent
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer2437904
    101950640001
    ELLIS, Gareth Bryn
    26 Clos Rheidol
    NP26 4JD Caldicot
    Gwent
    Geschäftsführer
    26 Clos Rheidol
    NP26 4JD Caldicot
    Gwent
    United KingdomBritishCo Director77322140001
    TREMLETT, Michael
    Homefield House
    Upton Lane
    BS41 8NW North Wick
    Bristol
    Geschäftsführer
    Homefield House
    Upton Lane
    BS41 8NW North Wick
    Bristol
    United Kingdom BritishCo Director64138490003
    HIGHSTONE SECRETARIES LIMITED
    Highstone House
    165 High Street
    EN5 5SU Barnet
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    Highstone House
    165 High Street
    EN5 5SU Barnet
    Hertfordshire
    900014180001
    WILLIAMS, Ian David
    2 Lime Kiln Court
    Llanvaches
    NP26 3FF Caldicot
    South Wales
    Geschäftsführer
    2 Lime Kiln Court
    Llanvaches
    NP26 3FF Caldicot
    South Wales
    United KingdomWelshCo Director25450110003
    WILLIAMS, Steven
    10 Heol Tre Forys
    CF64 3RE Penarth
    Vale Of Glamorgan
    Geschäftsführer
    10 Heol Tre Forys
    CF64 3RE Penarth
    Vale Of Glamorgan
    WalesBritishCo Director101472160001
    HIGHSTONE DIRECTORS LIMITED
    Highstone House
    165 High Street
    EN5 5SU Barnet
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Highstone House
    165 High Street
    EN5 5SU Barnet
    Hertfordshire
    900014170001

    Hat LEVANTINE 2003 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 14. März 2005
    Geliefert am 30. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 30. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. März 2005
    Geliefert am 30. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land and premises comprising the former electron filling station 113-123 windsor road, neath and the proceeds of sale thereof together with a floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment at any time placed upon or used in or about the property, fixed charge over all contracts and agreements, rents and licence fees, insurances in relation to the property, and an assignment of the goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 30. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Deposit of charge
    Erstellt am 14. März 2005
    Geliefert am 30. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The sum of £50,000 together with all sums in the company's bank account(s) with the mortgagee and all other sums of any currency whatsoever including interest accruing on such sums from time to time in the company's account(s).
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 30. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Juni 2003
    Geliefert am 24. Juni 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a electron filling station 113-123 windsor road neath t/n WA788012. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 24. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 05. Juni 2003
    Geliefert am 12. Juni 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0