ILLUSTRIOUS LOUNGING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ILLUSTRIOUS LOUNGING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04729627 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ILLUSTRIOUS LOUNGING LIMITED?
- Gaststätten und Bars (56302) / Gastgewerbe
Wo befindet sich ILLUSTRIOUS LOUNGING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 11 West Park HG1 1BL Harrogate North Yorkshire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ILLUSTRIOUS LOUNGING LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SUGARSPUN LIMITED | 10. Apr. 2003 | 10. Apr. 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ILLUSTRIOUS LOUNGING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ILLUSTRIOUS LOUNGING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Zweite Einreichung von AR01, das zuvor beim Handelsregister eingereicht wurde, erstellt am 10. Apr. 2011 | 16 Seiten | RP04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 6 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Samuel James Higginson am 10. Apr. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Billingham als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Samuel Higginson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , 76 Church Street, Lancaster, Lancs, LA1 1ET am 15. Sept. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 08. Juli 2010
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 7 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 7 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Stanyon als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Stanyon als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2006 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ILLUSTRIOUS LOUNGING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILLINGHAM, Andrew | Geschäftsführer | West Park HG1 1BL Harrogate 11 North Yorkshire United Kingdom | England | British | 154146020001 | |||||
| HIGGINSON, Martin James | Sekretär | Hay Carr Ellel LA2 0HJ Lancaster Lancashire | British | 154448310001 | ||||||
| STANYON, Andrew David | Sekretär | Burrow Cottage Burrow Hights Lane LA2 0PG Lancaster Lancashire | British | 104705890002 | ||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
| DUDACK, Lee Joseph | Geschäftsführer | The Laurels 29 Aldenham Avenue WD7 8HZ Radlett Hertfordshire | United Kingdom | British | 92527430001 | |||||
| HIGGINSON, Martin James | Geschäftsführer | Hay Carr Ellel LA2 0HJ Lancaster Lancashire | England | British | 154448310001 | |||||
| HIGGINSON, Samuel James | Geschäftsführer | 17b Three Kings Yard W1K 4JT London | United Kingdom | British | 117555110001 | |||||
| STANYON, Andrew David | Geschäftsführer | Burrow Cottage Burrow Hights Lane LA2 0PG Lancaster Lancashire | United Kingdom | British | 104705890002 | |||||
| YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
Hat ILLUSTRIOUS LOUNGING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 21. Nov. 2010 Geliefert am 27. Nov. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of equitable charge all assets, property and undertaking, together with all present and future equipment, plant, machinery, tools, vehicles, furniture, fittings, installations and apparatus and other tangible moveable propertyt see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Feb. 2006 Geliefert am 09. Feb. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £50,000.00 and all other monies due or to become due | |
Kurze Angaben L/H premises k/a unit 2 waring and gillows building, north road, lancaster also k/a toast, 25 north road, lancaster t/no LA841950, and the proceeds of sale of the property, and all buildings and fixtures (including trade fixtures), the insurance policy taken out in respect of the property and assigns the goodwill. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Juli 2003 Geliefert am 05. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Mai 2003 Geliefert am 06. Juni 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 60-62 church street lancaster t/n LA797365. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0