INHOCO 2833 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | INHOCO 2833 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04730527 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von INHOCO 2833 LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich INHOCO 2833 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 176-178 Pontefract Road Cudworth S72 8BE Barnsley South Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INHOCO 2833 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für INHOCO 2833 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Brantingham Property Services Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Michael Clive Crooks as a person with significant control on 09. Juni 2021 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2020 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Andrew Stuart Fish als Direktor am 13. Dez. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Clive Crooks als Geschäftsführer am 09. Juni 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2019 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2018 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Okt. 2017 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 047305270006 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 047305270006, erstellt am 29. Nov. 2016 | 26 Seiten | MR01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Apr. 2016 bis 31. Okt. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von INHOCO 2833 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISH, Andrew Stuart | Geschäftsführer | Welton HU15 1NB Brough Welton Grange East Yorkshire United Kingdom | England | British | Group Finance Director | 288712890001 | ||||
DUKES, Helen Larissa | Sekretär | Chapel Lane DN18 5PJ Barton-Upon-Humber 20 North Lincolnshire | British | Accounts Manager | 135720330001 | |||||
DUNFORD, Ann | Sekretär | 23 Wigginton Terrace YO31 8JD York | British | Company Secretary | 83068860003 | |||||
DUNFORD, Ann | Sekretär | 23 Wigginton Terrace YO31 8JD York | British | 83068860003 | ||||||
HOLMES, Ashley Julian | Sekretär | Poltair Meadow TR10 8SF Penryn 6 Cornwall England | 177873120001 | |||||||
A B & C SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006570001 | |||||||
CROOKS, Michael Clive | Geschäftsführer | Ensor Mews SW7 3BT London 7 England | England | British | Director | 48504730026 | ||||
FISH, Andrew Stuart | Geschäftsführer | Burnleys View Methley LS26 9BQ Leeds 1 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant/Director | 99181180002 | ||||
FISH, Andrew Stuart | Geschäftsführer | Burnleys View Methley LS26 9BQ Leeds 1 | United Kingdom | British | Accountant/Director | 99181180002 | ||||
INHOCO FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INHOCO 2833 LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Michael Clive Crooks | 30. Apr. 2016 | Pontefract Road Cudworth S72 8BE Barnsley 176-178 South Yorkshire | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Brantingham Property Services Limited | 06. Apr. 2016 | Pontefract Road Cudworth S72 8BE Barnsley 176-178 South Yorkshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat INHOCO 2833 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 29. Nov. 2016 Geliefert am 02. Dez. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 4 barker lane, york and land to the south west, being the land comprised in land registry title number NYK260885. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 10. Nov. 2011 Geliefert am 22. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the group members (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land adjoining 70 upper allen street, sheffield t/n SYK574058 by way of fixed charge the benefit of all agreements relating to the property, the rights under the apportionment of any managing agent, all rights title and interest in all contracts or policies of insurances, the benefit of all authorisations consents approvals resolutions, rights title and interest in and to the rental income. Assigns all rights title and interest both in rental income and all other rights. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. Dez. 2010 Geliefert am 10. Dez. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the group members (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 29. Jan. 2010 Geliefert am 08. Feb. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Part of 70 upper allen street sheffield with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Juli 2003 Geliefert am 30. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 10. Juli 2003 Geliefert am 16. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The land at hope works furnace hill sheffield. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0