EDITION HOMES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEDITION HOMES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04731815
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EDITION HOMES LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich EDITION HOMES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EDITION HOMES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ROCKHILL HOMES LIMITED16. Mai 200316. Mai 2003
    WILLOUGHBY (430) LIMITED11. Apr. 200311. Apr. 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EDITION HOMES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für EDITION HOMES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für EDITION HOMES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Jan. 2016

    9 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    9 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 08. Jan. 2015

    10 Seiten4.68

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    7 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O C/O Paul John Construction Ltd Telford Way Stephenson Industrial Estate Coalville Leicestershire LE67 3HE United Kingdom* am 20. Dez. 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    4 SeitenRM01

    Ernennung eines Receivers oder Managers

    4 SeitenRM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Apr. 2013

    Kapitalaufstellung am 12. Apr. 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2012 bis 31. März 2013

    1 SeitenAA01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 22. Okt. 2012

    2 Seiten3.6

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 06. Juni 2012

    2 Seiten3.6

    legacy

    2 SeitenLQ02

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Scott Davidson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Mark David Poulson als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von David Twomlow als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Twomlow als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    6 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 4Th Floor City Gate East Tollhouse Hill Nottingham NG1 5FS* am 18. Jan. 2012

    1 SeitenAD01

    legacy

    2 SeitenLQ01

    legacy

    4 SeitenMG02

    Wer sind die Geschäftsführer von EDITION HOMES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    POULSON, Mark David
    Oldfield Lane
    Rothley
    LE7 7QD Leicester
    3
    England
    Sekretär
    Oldfield Lane
    Rothley
    LE7 7QD Leicester
    3
    England
    168568800001
    HENRY, John Timothy
    The Hovel
    Spinney Drive Kirby Grange
    LE9 9FG Botcheston
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    The Hovel
    Spinney Drive Kirby Grange
    LE9 9FG Botcheston
    Leicestershire
    EnglandBritish161954590001
    BROUDER, John Francis
    149 Scraptoft Lane
    LE5 2FF Leicester
    Leicestershire
    Sekretär
    149 Scraptoft Lane
    LE5 2FF Leicester
    Leicestershire
    British16306630001
    MCEWAN, Keith
    15 Sanders Road
    Quorn
    LE12 8JN Loughborough
    Leicestershire
    Sekretär
    15 Sanders Road
    Quorn
    LE12 8JN Loughborough
    Leicestershire
    British9631320003
    TWOMLOW, David John
    Manor Rise
    WS14 9RF Lichfield
    44
    Staffordshire
    Sekretär
    Manor Rise
    WS14 9RF Lichfield
    44
    Staffordshire
    British50893390001
    WILLOUGHBY CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    20 Low Pavement
    NG1 7EA Nottingham
    Nottinghamshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    20 Low Pavement
    NG1 7EA Nottingham
    Nottinghamshire
    900023630001
    BAGSHAW, Paul William Richard
    Rotherhill
    1 Church Lane Spoxton
    LE14 4PZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Rotherhill
    1 Church Lane Spoxton
    LE14 4PZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    United KingdomBritish75614770001
    DAVIDSON, Scott Innes
    Bottom Green Farm
    Bottom Green, Upper Broughton
    LE14 3BA Melton Mowbray
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Bottom Green Farm
    Bottom Green, Upper Broughton
    LE14 3BA Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish31525750002
    TWOMLOW, David John
    Manor Rise
    WS14 9RF Lichfield
    44
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Manor Rise
    WS14 9RF Lichfield
    44
    Staffordshire
    EnglandBritish50893390001
    WOOD, Timothy John
    Magnolia Cottage
    Green Lane Off Cockshot Lane
    WR7 4JZ Dormston
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Magnolia Cottage
    Green Lane Off Cockshot Lane
    WR7 4JZ Dormston
    Worcestershire
    United KingdomBritish104447140001
    WILLOUGHBY CORPORATE REGISTRARS LIMITED
    20 Low Pavement
    NG1 7EA Nottingham
    Nottinghamshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    20 Low Pavement
    NG1 7EA Nottingham
    Nottinghamshire
    900023620001

    Hat EDITION HOMES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 08. Okt. 2010
    Geliefert am 15. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the debtor to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H residential flats at hamilton fields hamilton leicester t/n LT416636 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 113. Juni 2011Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (LQ01)
    • 125. Okt. 2012Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (LQ02)
      • Aktenzeichen 1
    Legal charge
    Erstellt am 31. Juli 2009
    Geliefert am 06. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property being flats VT4 four chimneys crescent hampton vale peterborough, t/no.CB339582 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sol Construction Limited
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment of rental income
    Erstellt am 21. Juli 2009
    Geliefert am 23. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The assets and all rights under or in relation to the rental income and all claims relating to them see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Juni 2009
    Geliefert am 15. Juni 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £241,695 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    L/H land and premises k/a flats at V2 stewartby avenue, hampton vale, petersborough t/no CB339586.
    Berechtigte Personen
    • Clegg Accomodation Solutions Limited
    Transaktionen
    • 15. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge over deposit
    Erstellt am 09. Jan. 2009
    Geliefert am 14. Jan. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the entire right, title and interest in and to all money in any currency standing to the credit of the account numbered 0631855, sort code: 12-08-81 and all rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 2009
    Geliefert am 13. Jan. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a first and second floors VT2 hampton vale peterborough fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 206. Dez. 2013Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
      • Aktenzeichen 2
    Legal charge
    Erstellt am 09. Jan. 2009
    Geliefert am 13. Jan. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a first and second floors VT4 hampton vale peterborough fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 306. Dez. 2013Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (RM01)
      • Aktenzeichen 3
    Charge of agreement for lease
    Erstellt am 12. Okt. 2007
    Geliefert am 18. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from henry davidson developments limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    An agreement for lease dated 15 august 2007 relating to residential flats at the local centre off sandhills avenue, hamilton, leicester part t/no LT390439 and all money now and in the future due to the company pursuant to the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Charge of agreement for lease
    Erstellt am 10. Okt. 2007
    Geliefert am 13. Okt. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from henry davidson developments LTD (the debtor) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    An agreement for lease dated 25 july 2007 relating to residential flats at the local centre hampton vale peterborough and made between (1) the debtor) and (2) the company and all money due pursuant to the agreement.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 15. Aug. 2007
    Geliefert am 25. Aug. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat EDITION HOMES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Gregory Bill Judd
    3 Brindleyplace
    B1 2JB Birmingham
    Receiver Manager
    3 Brindleyplace
    B1 2JB Birmingham
    Alistair Charles Wright
    3 Brindley Place
    B1 2JB Birmingham
    Receiver Manager
    3 Brindley Place
    B1 2JB Birmingham
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jonathan Edward Cookson
    12th Floor, 11 Brindley Place
    2 Brunswick Square
    B1 2LP Birmingham
    Receiver Manager
    12th Floor, 11 Brindley Place
    2 Brunswick Square
    B1 2LP Birmingham
    R Crompton
    12th Floor 11 Brindleyplace 2 Brunswick Square
    Brindleyplace
    B1 2LP Birmingham
    Receiver Manager
    12th Floor 11 Brindleyplace 2 Brunswick Square
    Brindleyplace
    B1 2LP Birmingham
    3Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jonathan Edward Cookson
    12th Floor, 11 Brindley Place
    2 Brunswick Square
    B1 2LP Birmingham
    Receiver Manager
    12th Floor, 11 Brindley Place
    2 Brunswick Square
    B1 2LP Birmingham
    R Crompton
    12th Floor 11 Brindleyplace 2 Brunswick Square
    Brindleyplace
    B1 2LP Birmingham
    Receiver Manager
    12th Floor 11 Brindleyplace 2 Brunswick Square
    Brindleyplace
    B1 2LP Birmingham
    4
    DatumTyp
    09. Jan. 2014Beginn der Liquidation
    29. Apr. 2016Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Paul James Goodwin
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    Praktiker
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0