FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED

FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFRASERS VINCENT SQUARE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04734907
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    • Verwaltung von Immobilien auf Provisions- oder Vertragsbasis (68320) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    81 Cromwell Road
    London
    SW7 5BW
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FAIRPOINT PROPERTIES (VINCENT SQUARE) LIMITED15. Apr. 200315. Apr. 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 23. Juni 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    12 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    Rücktritt des Auditors

    2 SeitenAUD

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Juni 2013

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 05. Juni 2013

    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    12 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Valsec Company Secretarial Services Limited als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Seng Khoon Ng am 15. Apr. 2011

    1 SeitenCH03

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    19 SeitenMG01

    Ernennung von Valsec Company Secretarial Services Limited als Sekretär

    3 SeitenAP04

    Beendigung der Bestellung von Valad Secretarial Services Limited als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009

    12 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    NG, Seng Khoon
    81 Cromwell Road
    London
    SW7 5BW
    Sekretär
    81 Cromwell Road
    London
    SW7 5BW
    British90211410001
    CHIA, Khong Shoong
    Alexandra Road
    # 21-00 Alexandra Point
    438
    Singapore 119958
    Geschäftsführer
    Alexandra Road
    # 21-00 Alexandra Point
    438
    Singapore 119958
    SingaporeSingaporean141112510002
    LEAR, Simon John Patrick
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Geschäftsführer
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    United KingdomBritish138750860001
    QUEK, Stanley Swee Han, Dr
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Geschäftsführer
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    SingaporeSingaporean123800250001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Sekretär
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    British812680001
    MCS FORMATIONS LIMITED
    235 Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    Sekretär
    235 Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    69736830002
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Sekretär
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    RegistrierungsnummerSC219311
    133355520001
    VALSEC COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Sekretär
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer7307485
    154204150001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Geschäftsführer
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    UkBritish812680001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Geschäftsführer
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    UkBritish812680001
    CHEONG, Anthony Fook Seng
    263 River Valley Road
    No 13-20 Aspen Hegihts
    FOREIGN Singapore
    238309
    Singapore
    Geschäftsführer
    263 River Valley Road
    No 13-20 Aspen Hegihts
    FOREIGN Singapore
    238309
    Singapore
    Malaysian77121980001
    DODWELL, John Christopher
    1 Stable House Hope Wharf
    St Mary Church Street Rotherhithe
    SE16 4JX London
    Geschäftsführer
    1 Stable House Hope Wharf
    St Mary Church Street Rotherhithe
    SE16 4JX London
    United KingdomBritish95741610002
    HENG, Jeffrey Wah Yong
    60 Chuan Garden
    FOREIGN Singapore
    558570
    Singapore
    Geschäftsführer
    60 Chuan Garden
    FOREIGN Singapore
    558570
    Singapore
    Singaporean70088270001
    LEAR, Simon John Patrick
    2 Orchard Road
    TW1 1LY St Margarets
    Middlesex
    Geschäftsführer
    2 Orchard Road
    TW1 1LY St Margarets
    Middlesex
    United KingdomBritish107485520001
    LIM, Ee Seng
    56 Lorong Melayu
    Sinapore
    416942
    Geschäftsführer
    56 Lorong Melayu
    Sinapore
    416942
    SingaporeanSingaporean123920850001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    NG, Seng Khoon
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    Geschäftsführer
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    EnglandBritish90211410001
    VAN REYK, Philip
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    EnglandBritish76943220003
    MCS INCORPORATIONS LIMITED
    235 Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    Geschäftsführer
    235 Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    69737020001

    Hat FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 23. Dez. 2010
    Geliefert am 31. Dez. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company each obligor investor or the investors' guarantor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 31. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 19. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Assignment
    Erstellt am 19. Juli 2006
    Geliefert am 22. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The entire right title and interest in and to the specific contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 22. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Mai 2003
    Geliefert am 10. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property situate at 63-69 (odd) rochester row and 68 vincent square london SW1 title number NGL785625. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Mai 2003
    Geliefert am 10. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0