FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04734907 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?
- Verwaltung von Immobilien auf Provisions- oder Vertragsbasis (68320) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 81 Cromwell Road London SW7 5BW |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FAIRPOINT PROPERTIES (VINCENT SQUARE) LIMITED | 15. Apr. 2003 | 15. Apr. 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Valsec Company Secretarial Services Limited als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Seng Khoon Ng am 15. Apr. 2011 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 19 Seiten | MG01 | ||||||||||
Ernennung von Valsec Company Secretarial Services Limited als Sekretär | 3 Seiten | AP04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Valad Secretarial Services Limited als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2009 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG, Seng Khoon | Sekretär | 81 Cromwell Road London SW7 5BW | British | 90211410001 | ||||||||||
| CHIA, Khong Shoong | Geschäftsführer | Alexandra Road # 21-00 Alexandra Point 438 Singapore 119958 | Singapore | Singaporean | 141112510002 | |||||||||
| LEAR, Simon John Patrick | Geschäftsführer | Cromwell Road SW7 5BW London 81 | United Kingdom | British | 138750860001 | |||||||||
| QUEK, Stanley Swee Han, Dr | Geschäftsführer | Cromwell Road SW7 5BW London 81 | Singapore | Singaporean | 123800250001 | |||||||||
| BALCHIN, Mark Nicholas | Sekretär | 6 Fleming Close GU14 8BT Farnborough Hampshire | British | 812680001 | ||||||||||
| MCS FORMATIONS LIMITED | Sekretär | 235 Old Marylebone Road NW1 5QT London | 69736830002 | |||||||||||
| VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | Melville Street EH3 7NS Edinburgh 4a Scotland |
| 133355520001 | ||||||||||
| VALSEC COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | 20 Esplanade YO11 2AQ Scarborough Europa House North Yorkshire |
| 154204150001 | ||||||||||
| BALCHIN, Mark Nicholas | Geschäftsführer | 6 Fleming Close GU14 8BT Farnborough Hampshire | Uk | British | 812680001 | |||||||||
| BALCHIN, Mark Nicholas | Geschäftsführer | 6 Fleming Close GU14 8BT Farnborough Hampshire | Uk | British | 812680001 | |||||||||
| CHEONG, Anthony Fook Seng | Geschäftsführer | 263 River Valley Road No 13-20 Aspen Hegihts FOREIGN Singapore 238309 Singapore | Malaysian | 77121980001 | ||||||||||
| DODWELL, John Christopher | Geschäftsführer | 1 Stable House Hope Wharf St Mary Church Street Rotherhithe SE16 4JX London | United Kingdom | British | 95741610002 | |||||||||
| HENG, Jeffrey Wah Yong | Geschäftsführer | 60 Chuan Garden FOREIGN Singapore 558570 Singapore | Singaporean | 70088270001 | ||||||||||
| LEAR, Simon John Patrick | Geschäftsführer | 2 Orchard Road TW1 1LY St Margarets Middlesex | United Kingdom | British | 107485520001 | |||||||||
| LIM, Ee Seng | Geschäftsführer | 56 Lorong Melayu Sinapore 416942 | Singaporean | Singaporean | 123920850001 | |||||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Geschäftsführer | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | United Kingdom | British | 56953000002 | |||||||||
| MCCABE, Kevin Charles | Geschäftsführer | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | 109250000001 | ||||||||||
| NG, Seng Khoon | Geschäftsführer | 101 Coldershaw Road W13 9DU London | England | British | 90211410001 | |||||||||
| VAN REYK, Philip | Geschäftsführer | Cherry Tree House Chequers Lane RG27 0NT Eversley Hampshire | England | British | 76943220003 | |||||||||
| MCS INCORPORATIONS LIMITED | Geschäftsführer | 235 Old Marylebone Road NW1 5QT London | 69737020001 |
Hat FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 23. Dez. 2010 Geliefert am 31. Dez. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company each obligor investor or the investors' guarantor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment | Erstellt am 19. Juli 2006 Geliefert am 22. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The entire right title and interest in and to the specific contracts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Mai 2003 Geliefert am 10. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property situate at 63-69 (odd) rochester row and 68 vincent square london SW1 title number NGL785625. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Mai 2003 Geliefert am 10. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0