FAIRHOLD ATLAS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | FAIRHOLD ATLAS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04735472 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FAIRHOLD ATLAS LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich FAIRHOLD ATLAS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Berkeley House 304 Regents Park Road N3 2JX London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FAIRHOLD ATLAS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CITYSTEAD LIMITED | 03. Juli 2007 | 03. Juli 2007 |
TAYLOR WIMPEY UK LIMITED | 22. Juni 2007 | 22. Juni 2007 |
CITYSTEAD LIMITED | 07. Feb. 2006 | 07. Feb. 2006 |
WIMPEY 1880 LIMITED | 15. Apr. 2003 | 15. Apr. 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FAIRHOLD ATLAS LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für FAIRHOLD ATLAS LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 15. Apr. 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 29. Apr. 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 15. Apr. 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für FAIRHOLD ATLAS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 26 Seiten | AA | ||
legacy | 43 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 28 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 28 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 23 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Michael David Watson als Direktor am 22. Feb. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 21 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Eintragung der Belastung 047354720008, erstellt am 11. Okt. 2019 | 15 Seiten | MR01 | ||
Ernennung von Mr Paul Hallam als Direktor am 10. Juli 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Paul Hallam als Sekretär am 10. Juli 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Mr Daniel Lau als Sekretär am 10. Juli 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||
Change of details for Dellmes Gr Limited as a person with significant control on 29. März 2019 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 21 Seiten | AA | ||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 1 Seiten | CC04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Apr. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Berkeley House 304 Regents Park Road London N3 2JY England zum Berkeley House 304 Regents Park Road London N3 2JX am 29. März 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Molteno House 302 Regents Park Road Finchley London N3 2JX zum Berkeley House 304 Regents Park Road London N3 2JY am 01. Nov. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||
Eintragung der Belastung 047354720007, erstellt am 17. Sept. 2018 | 173 Seiten | MR01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von FAIRHOLD ATLAS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAU, Daniel | Sekretär | 304 Regents Park Road N3 2JX London Berkeley House England | 261075670001 | |||||||
HALLAM, Paul | Geschäftsführer | 304 Regents Park Road N3 2JX London Berkeley House England | England | British | Chartered Accountant | 260389200001 | ||||
MCGILL, Christopher Charles | Geschäftsführer | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | England | British | Managing Director | 158021700001 | ||||
PROCTER, William Kenneth | Geschäftsführer | Park Lane W1K 1RB London 35 England | England | British | Accountant | 179204780001 | ||||
WATSON, Michael David | Geschäftsführer | Park Lane W1K 1RB London 35 England | England | British | Chartered Accountant | 63440350001 | ||||
CARR, Peter Anthony | Sekretär | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | Director | 130306120001 | |||||
HALLAM, Paul | Sekretär | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | 167212900001 | |||||||
HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Sekretär | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | Director | 76844970003 | |||||
JORDAN, James John | Sekretär | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
PHILLIPS, James | Sekretär | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | Solicitor | 8364990001 | |||||
RAPLEY, Ian | Sekretär | 28a Ickwell Road SG18 9AB Northill Bedfordshire | British | 104372330001 | ||||||
WOLFSON, Alan | Sekretär | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | 55840480004 | ||||||
CML SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 2 Piries Place RH12 1EH Horsham West Sussex | 74740960001 | |||||||
CARNEY, Christopher | Geschäftsführer | 5 Ruxley Ridge KT10 0HZ Claygate Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 125216670001 | ||||
CARR, Peter Anthony | Geschäftsführer | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | England | British | Director | 130306120001 | ||||
HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Geschäftsführer | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | Director | 76844970003 | |||||
JENKINS, Stephen Adrian | Geschäftsführer | Kingsview Manor Road HP10 8JA Penn Buckinghamshire | United Kingdom | British | Finance Director | 49738660003 | ||||
JORDAN, James John | Geschäftsführer | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British | Company Secretary | 120602100002 | ||||
LEVERETT, Steven John | Geschäftsführer | 11 Derwent Close RH12 4GW Horsham West Sussex | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 70319900001 | ||||
MCGILL, Christopher Charles | Geschäftsführer | The Holloway HP27 0LR Whiteleaf The Old Barn Buckinghamshire | United Kingdom | British | Managing Director | 140593930001 | ||||
MURRIN, Jonathan Charles | Geschäftsführer | 10 Silhill Hall Road B91 1JU Solihull West Midlands | British | Chartered Accountant | 115863170001 | |||||
PEACOCK, Raymond Anthony | Geschäftsführer | 9 Grosvenor Road Finchley N3 1EY London | United Kingdom | British | Director | 75750250002 | ||||
PHILLIPS, James | Geschäftsführer | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | Solicitor | 8364990001 | |||||
PROCTER, William Kenneth | Geschäftsführer | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | England | British | Accountant | 98678880016 | ||||
RAPLEY, Ian | Geschäftsführer | Park Lane W1K 1RB London 35 | United Kingdom | British | Accountant | 152894020001 | ||||
REDFERN, Peter Timothy | Geschäftsführer | 5 Broadfield Road OX5 1UL Yarnton Oxfordshire | British | Chartered Accountant | 74208670003 | |||||
SUTCLIFFE, Ian Calvert | Geschäftsführer | Windlesham Lodge Westwood Road GU20 6LX Windlesham Surrey | United Kingdom | British | Director | 112534590002 | ||||
TCHENGUIZ, Vincent Aziz | Geschäftsführer | Park Lane W1K 1RB London 35 | United Kingdom | British | Director | 71890500003 | ||||
WATSON, Michael David | Geschäftsführer | Park Lane W1K 1RB London 35 England | England | British | Chartered Accountant | 63440350001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FAIRHOLD ATLAS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dellmes Gr Limited | 06. Apr. 2016 | 304 Regents Park Road N3 2JX London Berkeley House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat FAIRHOLD ATLAS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 11. Okt. 2019 Geliefert am 21. Okt. 2019 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung The property known as land on the north east side of elizabeth street, manchester registered at hm land registry under title number MAN13247. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 17. Sept. 2018 Geliefert am 26. Sept. 2018 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Freehold property known as 1/33 butterworth house, TS17 0JN registered at hm land registry under title number CE203040 and all the other plots of land listed in the instrument. For more details please refer to the instrument. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 12. März 2015 Geliefert am 17. März 2015 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Land on the east side of highley drive coventry t/no WM906708 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 28. Nov. 2011 Geliefert am 09. Dez. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from a charging company to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever and all monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including subsidiary shares, investments, intellectual property, goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A supplemental legal charge supplemental to a debenture dated 19 december 2008 and | Erstellt am 25. Okt. 2011 Geliefert am 08. Nov. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Each property and all fixtures on such property, its rights under a managing agent's agreement, all right, title and interest in and to each agreement. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal charge relating to a deed of debenture dated 19 december 2008 and | Erstellt am 20. Feb. 2009 Geliefert am 02. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H land known as 2-6 (even) oakwood park bury road radcliffe manchester t/n MAN12227, forming part of the development known as oakwood park see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal charge | Erstellt am 19. Dez. 2008 Geliefert am 08. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly k/a citystead limited to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right, title and interest in and to the legally mortgaged property being - f/h land at highley drive radford coventry k/a sovereign court and also k/a flats at blakely court t/no WM906708; f/h land and buildings on the west side of monkmoor road, shrewsbury, shropshire k/a rose hill t/no SL173695; f/h land k/a the weaver lodge hotel, uttoexeter, staffordshire k/a windsor gardens t/no SF520430, for details of further properties charged please refer to form 395 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 19. Dez. 2008 Geliefert am 06. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company formerly k/a citystead limited to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0