SWAMF (GP) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSWAMF (GP) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04736787
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SWAMF (GP) LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich SWAMF (GP) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SWAMF (GP) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SACKVILLE TCI PROPERTY (GP) LIMITED12. Juni 200312. Juni 2003
    2206TH SINGLE MEMBER SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED16. Apr. 200316. Apr. 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SWAMF (GP) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für SWAMF (GP) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    10 SeitenLIQ13

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Charterhall House Charterhall Drive Chester Cheshire CH88 3AN geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 33 Old Broad Street London EC2N 1HZ zum 1 More London Place London SE1 2AF am 31. Juli 2019

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Juli 2019

    LRESSP

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 29. Juni 2018 bis 28. Juni 2018

    3 SeitenAA01

    Bestätigungserklärung erstellt am 16. Apr. 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 30. Juni 2018 bis 29. Juni 2018

    3 SeitenAA01

    Erfüllung der Belastung 28 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 43 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 44 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 64 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 35 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 41 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 60 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 18 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 67 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 66 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 65 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 53 vollständig

    4 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von SWAMF (GP) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Sekretär
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer02791894
    73512200003
    MCGOWAN, Iain Ross
    Lloyds Banking Group Plc
    69 Morrison Street
    EH3 8YF Edinburgh
    Insurance Company Secretariat
    Scotland
    Scotland
    Geschäftsführer
    Lloyds Banking Group Plc
    69 Morrison Street
    EH3 8YF Edinburgh
    Insurance Company Secretariat
    Scotland
    Scotland
    ScotlandBritishCompany Director185958620001
    WILLIAMS, Marie Elaine
    Morrison Street
    EH3 8YF Edinburgh
    69
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Morrison Street
    EH3 8YF Edinburgh
    69
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector206388510001
    DARLING, Shona Mary
    Flat 11
    76 Eyre Place
    EH3 5EZ Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    Flat 11
    76 Eyre Place
    EH3 5EZ Edinburgh
    Midlothian
    BritishCompany Secretary110522070002
    KAYE, Alan
    15 Edge Hill Avenue
    N3 3AY London
    Sekretär
    15 Edge Hill Avenue
    N3 3AY London
    British21908430001
    SMITH, Kate Susan
    Drylawhill
    East Linton
    EH40 3AZ East Lothian
    7
    Sekretär
    Drylawhill
    East Linton
    EH40 3AZ East Lothian
    7
    Other132379630001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Bevollmächtigter Sekretär
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900024810001
    CHANNING, Michael Francis Arthur
    19 Seton Place
    EH9 2JT Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    19 Seton Place
    EH9 2JT Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishDirector101660670001
    CLATWORTHY, James Edward
    Lloyds Banking Group Plc
    69 Morrison Street
    EH3 8YF Edinburgh
    Insurance Company Secretariat
    Scotland
    Scotland
    Geschäftsführer
    Lloyds Banking Group Plc
    69 Morrison Street
    EH3 8YF Edinburgh
    Insurance Company Secretariat
    Scotland
    Scotland
    EnglandBritishCompany Director157147450001
    FERGUSON, James Gerard
    Boclair Road
    G64 2NB Glasgow
    23
    Geschäftsführer
    Boclair Road
    G64 2NB Glasgow
    23
    United KingdomBritishDirector100078130002
    HUNTER, Kerri
    60 Morrison Street
    EH3 8BE Edinburgh
    Edinburgh One
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    60 Morrison Street
    EH3 8BE Edinburgh
    Edinburgh One
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director166233600001
    JORDISON, Donald
    117 The Avenue
    Ealing
    W13 8JT London
    Geschäftsführer
    117 The Avenue
    Ealing
    W13 8JT London
    BritishChartered Surveyor79821950001
    LAIDLAW, Thomas Baillie
    15 Liberton Drive
    EH16 6NL Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    15 Liberton Drive
    EH16 6NL Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishChartered Surveyor61231540001
    MURRAY, Cameron Shaun
    Stafford Street
    EH3 7BD Edinburgh
    32a
    Geschäftsführer
    Stafford Street
    EH3 7BD Edinburgh
    32a
    BritishChartered Surveyor115949270001
    NAISH, Robert Malcolm
    Morrison Street
    EH3 8BE Edinburgh
    60
    Uk
    Geschäftsführer
    Morrison Street
    EH3 8BE Edinburgh
    60
    Uk
    United KingdomBritishDirector3418680003
    NOVEMBER, Andrew John
    16 Netherby Road
    EH5 3NA Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    16 Netherby Road
    EH5 3NA Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritishDirector98649160001
    RIGG, James Mark Alexander
    3b Marjorie Grove
    SW11 5SH London
    Geschäftsführer
    3b Marjorie Grove
    SW11 5SH London
    BritishChartered Surveyor67445210001
    STRANG, Andrew David
    Woodcote Lodge
    Snows Ride
    GU20 6PE Windlesham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Woodcote Lodge
    Snows Ride
    GU20 6PE Windlesham
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor3903450001
    WARD, Daniel
    7 First Street
    SW3 2LB London
    Geschäftsführer
    7 First Street
    SW3 2LB London
    BritishChartered Surveyor40210560002
    WILLCOCK, John Marcus
    21 Gartons Road
    Middleleaze
    SN5 5TR Swindon
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    21 Gartons Road
    Middleleaze
    SN5 5TR Swindon
    Wiltshire
    United KingdomBritishAccountant76276580001
    LOVITING LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900024790001
    SERJEANTS' INN NOMINEES LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900024800001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SWAMF (GP) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer3196171
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat SWAMF (GP) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge
    Erstellt am 15. Apr. 2004
    Geliefert am 16. Apr. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company as general partner of threadneedle capital and income property fund, a limited partnership to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property known as 26A, 26B and 26C albermarle street london t/no NGL559865; all buildings and other structures on, and items fixed to, the property; any goodwill relating to the property or the business or undertaking conducted at the property; all plant, machinery and other items affixed and forming part of the property on or at any time after the date of this charge; and the proceeds of any claim made under any insurance policy.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 15. Dez. 2003
    Geliefert am 16. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 1-40 bury street, abingdon, t/n BK93727, ON72730,ON120560 and BK66269. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 15. Dez. 2003
    Geliefert am 16. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Mardel house, 18-28 shoplatch, 16 and 20-28 (inclusive) claremont street and 4 bellstone, shrewsbury, shropshire,leasehold, t/n SL65209. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 29, 30 and 33 herschel street and 1 to 5 (odd) alpha street, slough (together known as pegasus court) t/nos BK225924 and BK277522. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 6 greengate street and 18 martin street, stafford t/n SF259916. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as land and buildings on the west side of victoria road, fenton, stoke on trent t/n SF107449. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 8-10 high street, sutton, surrey t/n SGL85930 and SY127373. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as wakefield wing, stamford hospital, ravenscourt park, hammersmith, london W6 t/n BGL27128. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as mulliner house (formerly known as bedford park works) flanders road, turnham green t/n NGL409750. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as western avenue business centre, kendal avenue, london W3 t/nos NGL565625, AGL17517 and NGL565624. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 171, 172 and 173 tottenham court road, london t/n LN78234. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 36, 37 and 38 fitzroy square, st pancras, london W1 t/n NGL303293. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H and l/h property known as 4 and 5 friargate, preston t/nos LA701042 (4 friargate) , LA543875 (5 friargate) and with good l/h title under t/n LA543876 (4 friargate). By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 141 high street and 1-5 wellington parade, barnet t/n NGL9121. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property known as kelpatrick road, slough (also known as land at the rear of 452 bath road, slough) t/n BK363084. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property known as burryport road, northampton t/n NN125001. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property known as cornbrash park, bumpers way, chippenham, wiltshire t/n WT124207. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as 41-43 park street, walsal, west midlands WS1 1LY t/n WM409059. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as neville house, mount ephraim, tunbridge wells, kent t/n K518439. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as former homebase unit, area 3C pagoda west, westmad industrial estate, swindon t/n WT73885. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as sites g, h and 1, west hove industrial estate, bournemouth t/n DT196981. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as land and buildings on the east side of stony lane, christchurch, dorset t/n DT142638. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as ashby house (formerly part of globe house) new street, chelmsford, essex and ancillary parking t/nos EX574280 and EX596148. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property known as beta unit, woodlands lane, almondsbury, bristol t/n GR214120. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 18. Sept. 2003
    Geliefert am 19. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property 68 english street and 1 highland laddie lane, carlisle, cumbria CA3 8JQ t/n CU67020. By way of fixed charge all buildings and other structures on, and items fixed to, the property, any goodwill of the business, all plant machinery and other fixtures and fittings, and the proceeds of any claim under any insurance policy relating to any of the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat SWAMF (GP) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Juli 2019Beginn der Liquidation
    07. Jan. 2021Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0