CORBIN & KING HOTEL GROUP LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CORBIN & KING HOTEL GROUP LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 04739085 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CORBIN & KING HOTEL GROUP LIMITED?
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich CORBIN & KING HOTEL GROUP LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 157-160 Piccadilly W1J 9EB London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CORBIN & KING HOTEL GROUP LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CORBIN & KING LIMITED | 12. Feb. 2014 | 12. Feb. 2014 |
REX RESTAURANT ASSOCIATES LIMITED | 22. März 2007 | 22. März 2007 |
CKL RESTAURANTS LIMITED | 18. Sept. 2003 | 18. Sept. 2003 |
NEWINCCO 263 LIMITED | 18. Apr. 2003 | 18. Apr. 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CORBIN & KING HOTEL GROUP LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CORBIN & KING HOTEL GROUP LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 19 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Apr. 2022 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Corbin & King Limited as a person with significant control on 01. Feb. 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 17 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Apr. 2021 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 18 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Ms Zuleika Fennell am 26. März 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy Richard Bruce King am 17. Juli 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Apr. 2020 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 18 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Apr. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2018 | 23 Seiten | AA | ||
Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. März 2019 bis 31. Dez. 2018 | 3 Seiten | AA01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy Richard Bruce King am 15. Juni 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Zuleika Fennell am 19. Apr. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||
Change of details for Minor C&K Limited as a person with significant control on 25. Jan. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Apr. 2018 mit Aktualisierungen | 8 Seiten | CS01 | ||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 10 Norwich Street London EC4A 1BD verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Anne Sophia Hogg als Geschäftsführer am 23. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von John Chester Botts als Geschäftsführer am 18. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Karen Elisabeth Dind Jones als Geschäftsführer am 18. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Einzelheiten zur Änderung der an Aktien geknüpften Rechte | 3 Seiten | SH10 | ||
Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse | 2 Seiten | SH08 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von CORBIN & KING HOTEL GROUP LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORBIN, Christopher John | Geschäftsführer | Piccadilly W1J 9EB London 157-160 | United Kingdom | British | Restaurateur | 70317030003 | ||||
FENNELL, Zuleika | Geschäftsführer | Piccadilly W1J 9EB London 157-160 | England | British | Director | 211007430003 | ||||
KING, Jeremy Richard Bruce | Geschäftsführer | Piccadilly W1J 9EB London 157-160 | England | British | Restaurateur | 185711480004 | ||||
FENNELL, Zuleika | Sekretär | Avenue Park Road SE27 9BT London 12d | British | 131618290001 | ||||||
KING, Jeremy Richard Bruce | Sekretär | Flat 34 1 Britton Street EC1M 5NW London | British | Restauranteur | 110276400001 | |||||
LANGRIDGE, Megan Joy | Sekretär | 42 Everest Drive Hoo St Werburgh ME3 9AW Rochester Kent | British | 86459820005 | ||||||
SMITH, Helen Susan | Sekretär | Piccadilly W1J 9EB London 157-160 | 149192960001 | |||||||
OLSWANG COSEC LIMITED | Sekretär | 90 High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor | 83864780002 | |||||||
BLACK, Robin Kennedy | Geschäftsführer | Piccadilly W1J 9EB London 157-160 | United Kingdom | British | Chartered Acccountant | 37965380001 | ||||
BOTTS, John Chester | Geschäftsführer | Piccadilly W1J 9EB London 157-160 | United Kingdom | American | Director | 2943960001 | ||||
DRYSDALE, Simon Christopher | Geschäftsführer | Piccadilly W1J 9EB London 157-160 | United Kingdom | British | Director | 105308290001 | ||||
EVERARD, Mitchell Lee | Geschäftsführer | Piccadilly W1J 9EB London 157-160 | United Kingdom | British | Restaurateur | 120600900001 | ||||
FENNELL, Zuleika | Geschäftsführer | Piccadilly W1J 9EB London 157-160 | United Kingdom | British | Director Of Human Resources | 131618290001 | ||||
GALVIN, Christopher John | Geschäftsführer | 71 Chelmsford Road CM15 8QP Shenfield Essex | British | Chef | 104713140001 | |||||
HOGG, Elizabeth Anne Sophia | Geschäftsführer | Piccadilly W1J 9EB London 157-160 | England | British | Cfo | 110796000003 | ||||
HOLLAND, Robert Milton | Geschäftsführer | 88 Louisville Road SW17 8RT London | United Kingdom | British | Restaurateur | 105105500001 | ||||
JACOBS, Alan Steven | Geschäftsführer | Piccadilly W1J 9EB London 157-160 | England | British | Director | 52186140001 | ||||
JONES, Karen Elisabeth Dind | Geschäftsführer | Piccadilly W1J 9EB London 157-160 | United Kingdom | British | Director | 47793260007 | ||||
KLIMT, Peter Richard | Geschäftsführer | Redington Road NW3 7RS London 54 | United Kingdom | British | Businessman | 23621230001 | ||||
LOEWI, David Michael | Geschäftsführer | 5 Back Lane NW3 1HL London | United Kingdom | British | Hotelier | 105018790001 | ||||
LYSE, Remy Rene | Geschäftsführer | 43 Bradstock Road Stoneleigh KT17 2LD Epsom | United Kingdom | French | Managing Director | 110276390001 | ||||
NAGGAR, Guy Anthony | Geschäftsführer | Avenue Road NW8 6HR London 61 | United Kingdom | Italian | Businessman | 1496660001 | ||||
PEARS, Mark Andrew | Geschäftsführer | 2 Old Brewery Mews Hampstead NW3 1PZ London | England | British | Company Director | 1447500008 | ||||
SMITH, Helen Susan | Geschäftsführer | Piccadilly W1J 9EB London 157-160 | United Kingdom | British | Director | 148974970001 | ||||
OLSWANG DIRECTORS 1 LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Seventh Floor 90 High Holborn WC1V 6XX London | 900026670001 | |||||||
OLSWANG DIRECTORS 2 LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 90 High Holborn WC1V 6XX London Seventh Floor | 900026650001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CORBIN & KING HOTEL GROUP LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corbin & King Limited | 08. Dez. 2017 | 100 Cannon Street EC4N 6EU London 2nd Floor | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Mr Jeremy Richard Bruce King | 06. Apr. 2016 | Piccadilly W1J 9EB London 157-160 | Ja | ||||||||||
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Graphite Capital General Partner Vii Llp | 06. Apr. 2016 | Berkeley Square W1J 6BQ London 4th Floor, Berkeley Square House United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat CORBIN & KING HOTEL GROUP LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 28. Okt. 2016 Geliefert am 31. Okt. 2016 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 13. Jan. 2016 Geliefert am 21. Jan. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The leasehold land being 9 islington green, london N1 2XH – land registry title number: NGL798954. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 23. Juli 2014 Geliefert am 26. Juli 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 23. Mai 2014 Geliefert am 28. Mai 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The l/h land being sherwood street restaurant sherwood street london t/no NGL923212. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 23. Mai 2014 Geliefert am 28. Mai 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The l/h land comprising the basement and ground floor of 50 marylebone high street london t/no's NGL912062 and NGL908028. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Key-man policy assignment | Erstellt am 11. Jan. 2013 Geliefert am 17. Jan. 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its rights title and interest in and to the proceeds of the policies. Policy number 40557988 in relation to jeremy richard bruce king see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 25. Apr. 2012 Geliefert am 04. Mai 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the security agent (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 13. Dez. 2011 Geliefert am 22. Dez. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 1 kingsway/51 aldwych london with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. Sept. 2011 Geliefert am 12. Okt. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. Sept. 2011 Geliefert am 12. Okt. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,500,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a 1572160 piccadilly and 1233 arlington street london t/n NGL824625 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 25. Mai 2007 Geliefert am 01. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 23. Mai 2007 Geliefert am 29. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H lower ground & ground floor 157-160 piccadilly & 1-3 arlington street london. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 07. Feb. 2005 Geliefert am 09. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £279,062.50 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben £279,062.50. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 12. Okt. 2004 Geliefert am 15. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Twenty three thousand five hundred pounds due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben A deposited sum of twenty three thousand and five hundred pounds by the tenant to the landlord. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 03. Nov. 2003 Geliefert am 07. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Nov. 2003 Geliefert am 07. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property known as lower ground and ground floor 157-160 piccadilly and 1-3 arlington street london W1J 9EB t/n NGL824625. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0