ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameASHBOURNE HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04743237
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED?

    • Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 31. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David Charles Lovett als Direktor am 31. Aug. 2012

    2 SeitenAP01

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    6 Seiten1.4

    Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs

    4 Seiten1.1

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Apr. 2012

    Kapitalaufstellung am 25. Apr. 2012

    • Kapital: GBP 3
    SH01

    Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    20 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Explanatory statement to sole member 14/05/2010
    RES13

    Wer sind die Geschäftsführer von ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LOVETT, David Charles
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    Geschäftsführer
    The Grange
    SW19 4PS London
    17
    England
    England
    United KingdomBritishDirector34419700002
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector163496070001
    KIME, Sean Thomas
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    Sekretär
    Flat 1
    3 Nevern Place
    SW5 9NR London
    British89002440002
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304760001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Sekretär
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Sekretär
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    BritishDirector103588940001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritishDirector79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritishDirector51697890003
    FLAHERTY, James Paul
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    Geschäftsführer
    Flat 18 Montagu Court
    27-29 Montagu Square
    W1H 2LG London
    AmericanDirector100530310001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector111188390002
    GOSLING, Mark David
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    Geschäftsführer
    Fosse Beck
    Bewerley
    HG3 5HX Harrogate
    BritishDirector66801660002
    JAP, Chee Miau
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    Geschäftsführer
    8 Thurloe Street
    SW7 2ST London
    United KingdomSingaporeanDirector101200680001
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Geschäftsführer
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritishDirector144822040001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritishDirector110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Geschäftsführer
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritishDirector26177180004
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritishDirector174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Geschäftsführer
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritishDirector77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Geschäftsführer
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritishDirector147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Geschäftsführer
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritishDirector147997950001
    STOREY, John
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    Geschäftsführer
    93 Dacre Park
    Blackheath
    SE13 5BX London
    BritishDirector60123860002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    Hat ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 29. Feb. 2008
    Geliefert am 14. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 14. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 06. Juni 2007
    Geliefert am 19. Juni 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 19. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Juli 2006
    Geliefert am 20. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 20. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession and charge
    Erstellt am 02. Dez. 2005
    Geliefert am 15. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Aug. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 01. Apr. 2005
    Geliefert am 19. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever or all monies due or to become due from cannon capital ventures limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Secured Creditors (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 10. Feb. 2005
    Geliefert am 24. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and cannon capital ventures limited to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage all estates or interests in any f/h or l/h property now owned by it, and all buildings and fixtures and fixed plant and fixed machinery, all of its book and other debts, any know-how, patent, trade mark, service mark, design, business name, any copyright or other intellectual property monopoly right. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Secured Creditors(The Security Agent)
    Transaktionen
    • 24. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Shares charge
    Erstellt am 17. Juni 2003
    Geliefert am 24. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the investments and all dividends, interest and other money. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./ N.V.
    Transaktionen
    • 24. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ASHBOURNE HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Juni 2012Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    20. Aug. 2012Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Praktiker
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0