GROVELEAF ESTATES LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGROVELEAF ESTATES LTD
    UnternehmensstatusVerwalter bestellt
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04769145
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GROVELEAF ESTATES LTD?

    • (7020) /

    Wo befindet sich GROVELEAF ESTATES LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    115 Craven Park Road
    London
    N15 6BL
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GROVELEAF ESTATES LTD?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Mai 2005
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. März 2006
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2004

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für GROVELEAF ESTATES LTD?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis19. Mai 2017
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung02. Juni 2017
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GROVELEAF ESTATES LTD?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für GROVELEAF ESTATES LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager

    4 SeitenRM02

    Änderung der Details des Direktors für Moishe Meisels am 25. Apr. 2019

    2 SeitenCH01

    legacy

    1 Seiten405(1)

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten405(1)

    legacy

    2 Seiten405(1)

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    7 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Mai 2004

    2 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    6 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von GROVELEAF ESTATES LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MEISELS, Chanie
    9 Gilda Crescent
    N16 6JT London
    Sekretär
    9 Gilda Crescent
    N16 6JT London
    American84967440001
    MEISELS, Moses
    Ferntower Road
    N5 2JG London
    4
    Greater London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ferntower Road
    N5 2JG London
    4
    Greater London
    United Kingdom
    EnglandEnglish71798640006
    M & K NOMINEE SECRETARIES LIMITED
    43 Wellington Avenue
    N15 6AX London
    Bevollmächtigter Sekretär
    43 Wellington Avenue
    N15 6AX London
    900004570001
    M & K NOMINEE DIRECTORS LIMITED
    43 Wellington Avenue
    N15 6AX London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    43 Wellington Avenue
    N15 6AX London
    900004560001

    Hat GROVELEAF ESTATES LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 07. Sept. 2007
    Geliefert am 19. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Commercial Acceptances (UK) Limited
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Charge
    Erstellt am 07. Sept. 2007
    Geliefert am 14. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from moshe meisels to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as the hotel mon bijou 47/49 manor road east cliff bournemouth t/n DT293372,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Commercial Acceptances (UK) Limited
    Transaktionen
    • 14. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Mai 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 11. Sept. 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
    • 204. Feb. 2022Mitteilung über das Aufhören der Tätigkeit als Verwalter oder Geschäftsführer (RM02)
      • Aktenzeichen 2
    Legal charge
    Erstellt am 13. Juli 2007
    Geliefert am 19. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h properties being 150 falcon road london t/n SGL166813, 133 homerton high street london t/n 318868, 103 upper clapton road london t/n LN50072, for details of further properties charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Commercial Acceptaces Limited
    Transaktionen
    • 19. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Jan. 2008Bestellung eines Verwalters oder Geschäftsführers (405 (1))
      • Aktenzeichen 1
    Debenture
    Erstellt am 13. Juli 2007
    Geliefert am 19. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Commercial Acceptances Limited
    Transaktionen
    • 19. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 11. März 2005
    Geliefert am 12. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. März 2005
    Geliefert am 12. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    123 streatham vale london t/no 401932. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. März 2005
    Geliefert am 12. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    133 homerton high street london t/no 318868. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. März 2005
    Geliefert am 12. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    103 upper capton road london t/no LN50072. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. März 2005
    Geliefert am 12. März 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    150 falcon road battersea london t/no SGL166813. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. März 2005Registrierung einer Belastung (395)

    Hat GROVELEAF ESTATES LTD Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Juli 2007Instrumentendatum
    Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jason Salter
    Coopers
    Dunmow Road
    CN5 0PE Abbess Roding
    Ongar
    Praktiker
    Coopers
    Dunmow Road
    CN5 0PE Abbess Roding
    Ongar
    2Receiver/Manager bestellt
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Jason Salter
    Coopers
    Dunmow Road
    CN5 0PE Abbess Roding
    Ongar
    Receiver Manager
    Coopers
    Dunmow Road
    CN5 0PE Abbess Roding
    Ongar
    Maurice Berger
    219 Golders Green Road
    NW11 9DD London
    Receiver Manager
    219 Golders Green Road
    NW11 9DD London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0