ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.4) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.4) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04784603 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.4) LIMITED?
- (7012) /
Wo befindet sich ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.4) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Castlegate House 36 Castle Street SG14 1HH Hertford Hertfordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.4) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.4) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 13 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Mai 2013 | 8 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Mai 2012 | 8 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Tyburn Lane Private Equity 43-44 Albemarle Street London W1S 4JJ am 20. Mai 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 5 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. März 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Thomas Paschal Walsh am 23. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Gordon Parker am 23. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Patrick O'hara am 23. Dez. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2009 bis 31. März 2010 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Andrew William Johnson am 02. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Richard Morgan als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für John Daly am 11. Dez. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philippa Dunkley als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2007 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.4) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN, David Richard | Sekretär | 36 Castle Street SG14 1HH Hertford Castlegate House Hertfordshire | 147590920001 | |||||||
| DALY, John Francis | Geschäftsführer | 36 Castle Street SG14 1HH Hertford Castlegate House Hertfordshire | United Kingdom | British | 78960760003 | |||||
| JOHNSON, Andrew William | Geschäftsführer | 15 Brondesbury Park NW6 0XX London | Great Britain | British | 68089410002 | |||||
| O'HARA, Patrick | Geschäftsführer | 36 Castle Street SG14 1HH Hertford Castlegate House Hertfordshire | England | Irish | 82724260003 | |||||
| PARKER, Gordon | Geschäftsführer | 36 Castle Street SG14 1HH Hertford Castlegate House Hertfordshire | England | Irish | 85330570006 | |||||
| WALSH, Thomas Paschal | Geschäftsführer | 36 Castle Street SG14 1HH Hertford Castlegate House Hertfordshire | United Kingdom | Irish | 130192900001 | |||||
| DUNKLEY, Philippa | Sekretär | Watcombe Cottages TW9 3BD Richmond 15 Surrey United Kingdom | Other | 124641320003 | ||||||
| PARKER, Gordon | Sekretär | Tayles Cottage 35 West End Street KT17 1XD Ewell Village Surrey | Irish | 85330570001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| MURRAY, David | Geschäftsführer | Kinsale 90 Lower Ham Road KT2 5BB Kingston Upon Thames Surrey | England | Irish | 100446830001 | |||||
| ROWAN, John Anthony | Geschäftsführer | 35 Ennersdale Road TW9 3PE Kew London | United Kingdom | Irish | 78960690001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.4) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental debenture | Erstellt am 11. Jan. 2005 Geliefert am 17. Jan. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the chargee or to the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage the property being hanover house manaton close matford business park marsh barton trading centre exeter t/no DN259632 all interests in the property all buildings and fixtures the proceeds of sale all plant and machinery the benefit of all contracts licenses and warranties. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 23. Dez. 2004 Geliefert am 31. Dez. 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the security trustee (whether on its own account or on behalf of any of the finance parties) or to the other finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed equitable charge the property being phase 8 gillingham business park, gillingham, kent t/no K576608 and all buildings and fixtures and fixed plant and machinery and all proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 10. Okt. 2003 Geliefert am 23. Okt. 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the security trustee or to the other finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property being land to the north of ambley road gillingham business park gillingham t/n K554993, all interests in the property, all buildings and fixtures, plant and machinery all computers vehicles office equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Juli 2003 Geliefert am 18. Juli 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the security trustee (whether on its own account or on behalf of any of the finance parties) or to the other finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Juli 2003 Geliefert am 14. Juli 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.4) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0