BENCH LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBENCH LIMITED
    UnternehmensstatusIn Verwaltung
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04787106
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BENCH LIMITED?

    • Großhandel mit Bekleidung und Schuhen (46420) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
    • Einzelhandel mit Bekleidung in spezialisierten Geschäften (47710) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich BENCH LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BENCH LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    AMERICANA INTERNATIONAL LIMITED21. Aug. 200321. Aug. 2003
    INHOCO 2853 LIMITED04. Aug. 200304. Aug. 2003
    AMERICANA INTERNATIONAL (2003) LIMITED28. Juli 200328. Juli 2003
    INHOCO 2853 LIMITED04. Juni 200304. Juni 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BENCH LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Juni 2017
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. März 2018
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis25. Juni 2016

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für BENCH LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis19. Apr. 2019
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung03. Mai 2019
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis19. Apr. 2018
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für BENCH LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    24 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    25 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    22 SeitenAM10

    Mitteilung über den Beschluss zur Abberufung des Administrators vom Amt

    13 SeitenAM16

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    23 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    4 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    22 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    28 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    29 SeitenAM10

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3 Hardman Street Spinningfields Manchester M3 3AT zum C/O Bdo Llp 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH am 28. Okt. 2021

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    34 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    4 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    30 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    30 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    30 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    40 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    30 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    6 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    28 SeitenAM10

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA

    14 SeitenAM02

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA

    11 SeitenAM02

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA

    11 SeitenAM02

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    4 SeitenAM06

    Vorschlag des Verwalters

    53 SeitenAM03

    Vorschlag des Verwalters

    51 SeitenAM03

    Wer sind die Geschäftsführer von BENCH LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer7038430
    146358090001
    KNIGHT, Barry Scott
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Geschäftsführer
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    United KingdomBritishNone224292410001
    COOPER, Anna Marie
    54 Parsonage Road
    Withington
    M20 4WQ Manchester
    Greater Manchester
    Sekretär
    54 Parsonage Road
    Withington
    M20 4WQ Manchester
    Greater Manchester
    British91115720001
    DONALDSON, Steven
    Park House
    1a Park Drive
    WA15 9DW Hale
    Cheshire
    Sekretär
    Park House
    1a Park Drive
    WA15 9DW Hale
    Cheshire
    BritishCompany Director59569960002
    MORGAN, Margaret Frances
    8 Hawkshaw Close
    Hawkshaw
    BL8 4GZ Bury
    Sekretär
    8 Hawkshaw Close
    Hawkshaw
    BL8 4GZ Bury
    IrishAccountant112262740001
    STOUT, Paul
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    Sekretär
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    BritishFinance Director140663950001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BAIRD, Gordon Martin
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone161091990001
    BROCK, David Michael
    Windyridge
    44 Beechwood Avenue
    HP6 6PN Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Windyridge
    44 Beechwood Avenue
    HP6 6PN Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChairman22121020001
    COOPER, Anna Marie
    54 Parsonage Road
    Withington
    M20 4WQ Manchester
    Greater Manchester
    Geschäftsführer
    54 Parsonage Road
    Withington
    M20 4WQ Manchester
    Greater Manchester
    BritishMerchandise Director91115720001
    DONALDSON, Steven
    Park House
    1a Park Drive
    WA15 9DW Hale
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Park House
    1a Park Drive
    WA15 9DW Hale
    Cheshire
    BritishCompany Director59569960002
    HAGUE, Simon David
    Horsted Lane
    Sharpthorne
    RH19 4HX East Grinsted
    Kixes Farm
    Geschäftsführer
    Horsted Lane
    Sharpthorne
    RH19 4HX East Grinsted
    Kixes Farm
    Great BritainBritishCompany Director142147510001
    HORRIDGE, Alan
    49 Daniels Lane
    WN8 9NH Skelmersdale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    49 Daniels Lane
    WN8 9NH Skelmersdale
    Lancashire
    BritishAccountant74178900001
    MASTERS, Paul Raymond
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    Geschäftsführer
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United KingdomBritishCompany Director135638050003
    MCGUIGAN, Peter
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    Geschäftsführer
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    EnglandBritishDirector136211350001
    MORGAN, Margaret Frances
    8 Hawkshaw Close
    Hawkshaw
    BL8 4GZ Bury
    Geschäftsführer
    8 Hawkshaw Close
    Hawkshaw
    BL8 4GZ Bury
    United KingdomIrishAccountant112262740001
    PEACOCK, Gregory Garth
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United Kingdom
    GermanyBritishFinance Director211457970001
    SAELZER, Bruno, Dr
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United Kingdom
    GermanyGermanChief Executive Officer195373380001
    STOUT, Paul
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    Geschäftsführer
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United KingdomBritishFinance Director140663950001
    TURNER, Mark Robert James
    The Rookery
    Bishopstone
    HP17 8SH Aylesbury
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Rookery
    Bishopstone
    HP17 8SH Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director101563880001
    VIDLER, Kelvin Bryan
    3 Churchfields
    Wybunbury
    CW5 7LL Nantwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    3 Churchfields
    Wybunbury
    CW5 7LL Nantwich
    Cheshire
    BritishCompany Director101430940001
    WOELFLE, Thomas, Dr
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ardwick Green North
    M12 6FZ Manchester
    Tanzaro House
    United Kingdom
    GermanyGermanChief Operations Officer203963520001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für BENCH LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    05. Apr. 2017Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen.

    Hat BENCH LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 05. Feb. 2016
    Geliefert am 08. Feb. 2016
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 27. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 01. Mai 2014
    Geliefert am 02. Mai 2014
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Beechbrook Mezzanine Ii Jersey Limited as Security Agent
    Transaktionen
    • 02. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 01. Mai 2014
    Geliefert am 01. Mai 2014
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 01. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 29. Apr. 2014
    Geliefert am 02. Mai 2014
    Ausstehend
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Beechbrook Mezzanine Ii Jersey Limited
    Transaktionen
    • 02. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 29. Apr. 2014
    Geliefert am 02. Mai 2014
    Ausstehend
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Beechbrook Mezzanine Ii Jersey Limited
    Transaktionen
    • 02. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 29. Apr. 2014
    Geliefert am 02. Mai 2014
    Ausstehend
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C
    Transaktionen
    • 02. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 29. Apr. 2014
    Geliefert am 02. Mai 2014
    Ausstehend
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C
    Transaktionen
    • 02. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 29. Apr. 2010
    Geliefert am 06. Mai 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    £18,829.39 or such other monies and interest.
    Berechtigte Personen
    • Freeport (Nominee 1) Limited and Freeport (Nominee 2) Limited
    Transaktionen
    • 06. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 09. Juli 2009
    Geliefert am 17. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the depopsit monies see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lasalle UK Ventures Property 11 S.A.R.L.
    Transaktionen
    • 17. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Senior german share pledge
    Erstellt am 30. März 2007
    Geliefert am 17. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and the borrowers and any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The pledgor pledges the registered fully paid up share capital being the one share in the company held by the pledgor with a nominal value of eur 50,000 all future and/or increased shares as well as rights for subscription of new shares all current and future rights and claims associated with the pledgors shares including dividends liquidation proceeds redemption proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mezzanine german share pledge
    Erstellt am 30. März 2007
    Geliefert am 17. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and by the mezzanine borrower and any other mezzanine obligor and each grantor to the chargee on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The pledgor pledges the registered fully paid up share capital being the one share in the company held by the pledgor with a nominal value of eur 50,000 all future and/or increased shares as well as rights for subscription of new shares all current and future rights and claims associated with the pledgors shares including dividends liquidation proceeds redemption proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 29. März 2007
    Geliefert am 11. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited Abn 12 004 044 937 (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 28. März 2007
    Geliefert am 13. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the investors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hg Pooled Management Limited (As Investor Security Trustee for the Investor Finance Parties)
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Share pledge agreement executed outside the united kingdom and comprising property situated there
    Erstellt am 25. Nov. 2005
    Geliefert am 20. Dez. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee and/or any other secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The exising shares and all additional shares in the capital of the company (americana germany gmbh) in whatever nominal value which the pledgor may aquire in the future in the event of a share transfer, an increase of the capital of the company or otherwise together with all ancillary rights and claims associated with the shares reffered to under clause 5 to the share pledge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited ("the Pledgee")
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Assignment by way of security
    Erstellt am 01. Nov. 2005
    Geliefert am 08. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by each of the obligors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Each policy and all policy proceeds and all its right title and interest present and future in each policy. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited in Its Capacity as Trustee and Security Agent for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 01. Nov. 2005
    Geliefert am 08. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by each of the obligors to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Australia Bank Limited in Its Capacity as Trustee and Security Agent for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 01. März 2004
    Geliefert am 05. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £88,125 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit of £88,125 is charged to the landlord under the rent deposit deed;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Equitable Life Assurance Society
    Transaktionen
    • 05. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Charge of deposit with the bank
    Erstellt am 07. Aug. 2003
    Geliefert am 13. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All deposits now and in the future credited to account designation national westminster bank PLC re: simon hague loan notes account account number 70515875 sort code 51-61-11 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of an insurance policy
    Erstellt am 07. Aug. 2003
    Geliefert am 13. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company has covenented to discharge all of the companys obligations and as a continuing security for such discharge and with full such discharge and with full title guarantee assigned to the bank the policy over the life of alan horridge with lutine assurance services limited (policy number 211374) and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of an insurance policy
    Erstellt am 07. Aug. 2003
    Geliefert am 13. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company has covenanted to discharge all of the companys obligations and as a continuing security for such discharge and with full title guarantee assigned to the bank the policy over the life of jonathan stuart white with lutine assurance services limited (policy number 211375) and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of an insurance policy
    Erstellt am 07. Aug. 2003
    Geliefert am 13. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company has covenanted to discharge all of the companys obligations and as a continuing security for such discharge and with full title guarantee assigned to the bank the policy over the life of margaret frances morgan with lutine assurance services limited (policy number 211376) and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of an insurance policy
    Erstellt am 07. Aug. 2003
    Geliefert am 13. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company has covenanted to discharge all of the companys obligations and as a continuing security for such discharge and with full title guarantee assigned to the bank the policy over the life of anna marie cooper with lutine assurance services limited (policy number 211386) and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment or redemption. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of an insurance policy
    Erstellt am 07. Aug. 2003
    Geliefert am 13. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company has covenanted to discharge all of the companys obligations and as a continuing security for such discharge and with full title guarantee assigned to the bank the policy over the life of simon david hague with lutine assurance services limited (policy number 211378) and all money that may become payable under the policy subject to re-assignment on redemption. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 07. Aug. 2003
    Geliefert am 13. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Isis Equity Partners PLC (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Aug. 2003
    Geliefert am 13. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BENCH LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    10. Mai 2018Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Kerry Bailey
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Martha Hanora Thompson
    Bdo Llp
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Antony David Nygate
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0