NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD
Überblick
| Unternehmensname | NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04787124 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Bradshaws, Charter Court, Well House Barns Chester Road Bretton CH4 0DH Chester United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CTP (HOLBECK) LIMITED | 23. Aug. 2011 | 23. Aug. 2011 |
| CTP ST JAMES (HOLBECK) LIMITED | 14. Sept. 2003 | 14. Sept. 2003 |
| INHOCO 2857 LIMITED | 04. Juni 2003 | 04. Juni 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Upton als Geschäftsführer am 27. Okt. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Simon Weiner als Geschäftsführer am 27. Okt. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Marcus Owen Shepherd als Geschäftsführer am 27. Okt. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Guy Illingworth als Direktor am 27. Okt. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 7a Howick Place London SW1P 1DZ England zum Bradshaws, Charter Court, Well House Barns Chester Road Bretton Chester CH4 0DH am 27. Okt. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Paul Whiteside als Sekretär am 27. Okt. 2020 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Chris Barton als Sekretär am 27. Okt. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bradley David Cassels als Geschäftsführer am 29. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Marcus Owen Shepherd als Direktor am 25. Sept. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Upton als Direktor am 25. Sept. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Matthew Simon Weiner als Direktor am 25. Sept. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Paul Whiteside als Sekretär am 31. März 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Paul Whiteside als Geschäftsführer am 31. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Bradley David Cassels als Direktor am 31. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITESIDE, John Paul | Sekretär | Chester Road Bretton CH4 0DH Chester Bradshaws, Charter Court, Well House Barns United Kingdom | 275847830001 | |||||||
| ILLINGWORTH, Guy | Geschäftsführer | Chester Road Bretton CH4 0DH Chester Bradshaws, Charter Court, Well House Barns United Kingdom | United Kingdom | British | 275845500001 | |||||
| BARTON, Chris | Sekretär | Howick Place SW1P 1DZ London 7a England | 207220820001 | |||||||
| TONKIN, Timothy Patrick | Sekretär | 32 Gledhow Wood Grove LS8 1NZ Leeds West Yorkshire | British | 61274100001 | ||||||
| WHITESIDE, John Paul | Sekretär | Howick Place SW1P 1DZ London 7a England | 162815660001 | |||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||
| CASSELS, Bradley David | Geschäftsführer | Howick Place SW1P 1DZ London 7a England | United Kingdom | British | 130724370005 | |||||
| QUARMBY, James Roger | Geschäftsführer | Arthington Park Arthington LS21 1PH Otley West Yorkshire | England | British | 3103200002 | |||||
| QUARMBY, Oliver Alexander | Geschäftsführer | 4th Floor Bridgewater Place Water Lane LS11 5BZ Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 80707560005 | |||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Geschäftsführer | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | United Kingdom | British | 41925000003 | |||||
| STROSS, Roland Peter | Geschäftsführer | 4th Floor Bridgewater Place Water Lane LS11 5BZ Leeds West Yorkshire | England | British | 153419870001 | |||||
| TOPHAM, David James | Geschäftsführer | c/o C/O Ctp Limited 7 Jordan Street M15 4PY Manchester Hill Quays United Kingdom | England | British | 92820080001 | |||||
| UPTON, Richard | Geschäftsführer | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | England | British | 204950320001 | |||||
| WEINER, Matthew Simon | Geschäftsführer | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | United Kingdom | British | 72888710002 | |||||
| WHITESIDE, John Paul | Geschäftsführer | Howick Place SW1P 1DZ London 7a England | England | British | 16769540006 | |||||
| INHOCO FORMATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northpoint Developments (No 1) Ltd | 06. Apr. 2016 | Howick Place SW1P 1DZ London 7a England England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over cash deposit (proceeds account) | Erstellt am 12. Feb. 2004 Geliefert am 26. Feb. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit and all the present and future titles and benefits of the company whatsoever in the deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Feb. 2004 Geliefert am 24. Feb. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the property known as land and buildings at holbeck village water lane holbeck leeds t/ns WYK483902, WYK100796, WYK247098, WYK531552 an DWYK714767. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Feb. 2004 Geliefert am 24. Feb. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land known as holbeck village water lane holbeck leeds t/ns WYK483902, WYK100796, WYK247098, WYK531552 and WYK714767. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over rent account | Erstellt am 12. Feb. 2004 Geliefert am 24. Feb. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The rent account and all rights, title and benefit in the rent account. The rent account means all sums together with all interest and other monies accruing on such sum standing to the credit of the charged account (sort code 12-08-83 numbered 06970008). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0