INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04789693 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Cannon Place 78 Cannon Street EC4N 6AF London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| PRECIS (2361) LIMITED | 06. Juni 2003 | 06. Juni 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juni 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Juni 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Juni 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Biif Corporate Services Limited als Geschäftsführer am 25. Jan. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Ivor Cavill als Direktor am 04. Sept. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nestor Augusto Castillo Borrero als Geschäftsführer am 04. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Biif Corporate Services Limited am 01. Juli 2015 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Dundas & Wilson North West Wing Bush House Aldwych London WC2B 4EZ zum Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF am 01. Juli 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nigel Wythen Middleton am 11. Nov. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Biif Corporate Services Limited als Direktor | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Nestor Augusto Castillo Borrero als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Forrest als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Forrest am 21. Mai 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Forrest am 11. Nov. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED | Sekretär | Floor 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd United Kingdom |
| 128530180002 | ||||||||||
| CAVILL, John Ivor | Geschäftsführer | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place United Kingdom | England | British | 152521640008 | |||||||||
| MIDDLETON, Nigel Wythen | Geschäftsführer | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place United Kingdom | United Kingdom | British | 156912990002 | |||||||||
| LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES LTD | Sekretär | 100 Wood Street EC2V 7EX London Fifth Floor United Kingdom |
| 90842510001 | ||||||||||
| OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Level 1 Exchange House Primrose Stret EC2A 2HS London | 900019420001 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BELL, Andrew | Geschäftsführer | West Hill Park N6 6ND London 39 | England | British | 136926040003 | |||||||||
| BUSBY, Colin Ronald William | Geschäftsführer | 34 Duloe Road PE19 8FQ St Neots Cambridgeshire | England | British | 109817700001 | |||||||||
| CASTILLO BORRERO, Nestor Augusto | Geschäftsführer | 16 Palace Street SW1E 5JD London 3i United Kingdom | England | British | 182601420001 | |||||||||
| ELLIOTT, Christopher James | Geschäftsführer | 1 Churchill Place E14 5HP London | United Kingdom | British | 31541950004 | |||||||||
| FORREST, Michael | Geschäftsführer | c/o Dundas & Wilson Aldwych WC2B 4EZ London North West Wing Bush House | United Kingdom | British | 169634490002 | |||||||||
| HOGG, Cressida Mary | Geschäftsführer | W11 | England | British | 85643820001 | |||||||||
| JENNINGS, Oliver James Wake | Geschäftsführer | Barclays Bank 1 Churchill Place E14 5HP London | United Kingdom | British | 86815910002 | |||||||||
| JONES, Nigel Stuart | Geschäftsführer | 3 Osprey Court Star Place E1W 1AG London | British | 99472630001 | ||||||||||
| KING, Neil Edmund | Geschäftsführer | Annables Manor Annables Lane AL5 3PR Herpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 115057710001 | |||||||||
| LEATHES, Simon William De Mussenden | Geschäftsführer | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 9808160003 | ||||||||||
| MCCLATCHEY, Robert Sean | Geschäftsführer | 1 Churchill Place E14 5HP London Barclays Bank Plc | United Kingdom | British | 140441450001 | |||||||||
| MONTAGUE, Adrian Alastair, Sir | Geschäftsführer | Gso Business Park G74 5PG East Kilbride British Energy | United Kingdom | British | 70647930007 | |||||||||
| RYAN, Michael Joseph | Geschäftsführer | Central Building 3 Matthew Parker Street SW1H 9NE London Apartment 42, | United Kingdom | Irish | 77999320003 | |||||||||
| SCOTT-BARRETT, Nicholas Huson | Geschäftsführer | Gatehouse Farm Crown Lane, Ardleigh CO7 7QZ Colchester | British | 59658050001 | ||||||||||
| VICKERSTAFF, Matthew | Geschäftsführer | 2 Saint Andrews Avenue AL5 2RA Harpenden Hertfordshire | British | 75379800001 | ||||||||||
| BIIF CORPORATE SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place United Kingdom |
| 188111290001 | ||||||||||
| PEREGRINE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Level 1 Exchange House Primrose Street EC2A 2HS London | 900019410001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biif Bidco Limited | 06. Apr. 2016 | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 09. Jan. 2009 Geliefert am 19. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of confirmation | Erstellt am 27. Nov. 2008 Geliefert am 06. Dez. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares and all related rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of confirmation | Erstellt am 27. Nov. 2008 Geliefert am 06. Dez. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares together with the related rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge and assignment | Erstellt am 29. Jan. 2008 Geliefert am 08. Feb. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from infrastructure investors limited (in its capacity as manager of the borrower under the deed) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of a first fixed charge its whole right title and interest in and to the shares together with the related rights, the investments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge and assignment | Erstellt am 20. Dez. 2007 Geliefert am 27. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares the related rights, the investments and the receivables,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed to deed of charge and assignment dated 21 december 2006 | Erstellt am 19. Dez. 2007 Geliefert am 28. Dez. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The right title and interest in and to the shares and investments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge and assignment | Erstellt am 30. Nov. 2007 Geliefert am 11. Dez. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The shares together with the related rights; and the investments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed to deed of charge and assignment dated 21 december 2006 | Erstellt am 09. Nov. 2007 Geliefert am 23. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge its whole right,title and interest in and to the shares together with related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge and assignment | Erstellt am 29. Dez. 2006 Geliefert am 06. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge all the shares together with the related rights,all the investments together with the related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge and assignment | Erstellt am 21. Dez. 2006 Geliefert am 05. Jan. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the shares in eastbrook facilities holdings 2 limited, normanby healthcare group holdings limited, anavon holdings limited with the related rights meaning all dividends, distributions and other income and all investments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0