GOLDEN LIVING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGOLDEN LIVING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04795462
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GOLDEN LIVING LIMITED?

    • Bau von Wohngebäuden (41202) / Bauwesen

    Wo befindet sich GOLDEN LIVING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Fairview House
    Victoria Place
    CA1 1HP Carlisle
    Cumbria
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GOLDEN LIVING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GILLMOOR LIMITED11. Juni 200311. Juni 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GOLDEN LIVING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für GOLDEN LIVING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    10 SeitenLIQ14

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 8D Lockside Office Park Lockside Road Preston Lancashire PR2 2YS zum Fairview House Victoria Place Carlisle Cumbria CA1 1HP am 21. Apr. 2020

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Vermögensübersicht

    8 SeitenLIQ02

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 24. März 2020

    LRESEX

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Juni 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2018

    22 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Juni 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2017

    22 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 11. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2016

    21 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Juli 2016

    Kapitalaufstellung am 24. Juli 2016

    • Kapital: GBP 5,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2015

    18 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 047954620011, erstellt am 23. Feb. 2016

    19 SeitenMR01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 11. Juli 2015

    • Kapital: GBP 5,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2014

    18 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Juli 2014

    Kapitalaufstellung am 04. Juli 2014

    • Kapital: GBP 5,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2013

    18 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Anthony Francis Lochery am 01. Juli 2013

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2012

    19 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Unit 3 Lockside Office Park Lockside Road Preston Lancs PR2 2YS United Kingdom* am 08. Jan. 2013

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Jason Lee William Parkinson als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Ian Bloomfield als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Wer sind die Geschäftsführer von GOLDEN LIVING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PARKINSON, Jason Lee William
    Victoria Place
    CA1 1HP Carlisle
    Fairview House
    Cumbria
    Sekretär
    Victoria Place
    CA1 1HP Carlisle
    Fairview House
    Cumbria
    171785380001
    LOCHERY, Anthony Francis
    Cow Lane
    Whissendine
    LE15 7HJ Oakham
    The Pastures
    Rutland
    England
    Geschäftsführer
    Cow Lane
    Whissendine
    LE15 7HJ Oakham
    The Pastures
    Rutland
    England
    EnglandBritish18996670004
    BLOOMFIELD, Ian Andrew
    8 Emsworth Drive
    M33 3PR Brooklands
    Cheshire
    Sekretär
    8 Emsworth Drive
    M33 3PR Brooklands
    Cheshire
    British91107180001
    BROOKE, Leslie
    8 Bramble Croft
    Chewmoor Lane Lostock
    BL6 4GW Bolton
    Lancashire
    Sekretär
    8 Bramble Croft
    Chewmoor Lane Lostock
    BL6 4GW Bolton
    Lancashire
    British76496080004
    RAINFORD, Stephen Thomas
    5 Badgers Walk
    Euxton
    PR7 6FH Chorley
    Lancashire
    Sekretär
    5 Badgers Walk
    Euxton
    PR7 6FH Chorley
    Lancashire
    British80681050001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    DAUBNEY, Stephen Gordon
    9 Rosebank, Stubbins
    Ramsbottom
    BL0 0PY Bury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    9 Rosebank, Stubbins
    Ramsbottom
    BL0 0PY Bury
    Lancashire
    EnglandBritish34016500003
    DEAN, Geoffrey Alan
    7 Wallets Wood Court
    Chorley
    PR7 2FT Lancashire
    Geschäftsführer
    7 Wallets Wood Court
    Chorley
    PR7 2FT Lancashire
    British29832240004
    RAINFORD, Stephen Thomas
    5 Badgers Walk
    Euxton
    PR7 6FH Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    5 Badgers Walk
    Euxton
    PR7 6FH Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish80681050001
    WALTERS THOMPSON, Trevor William
    35 Boroughbridge Road
    HG5 0ND Knaresborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    35 Boroughbridge Road
    HG5 0ND Knaresborough
    North Yorkshire
    United KingdomBritish105120850001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GOLDEN LIVING LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Anthony Francis Lochery
    Victoria Place
    CA1 1HP Carlisle
    Fairview House
    Cumbria
    01. Mai 2017
    Victoria Place
    CA1 1HP Carlisle
    Fairview House
    Cumbria
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.

    Hat GOLDEN LIVING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 23. Feb. 2016
    Geliefert am 27. Feb. 2016
    Ausstehend
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Feb. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    Charge over building contract
    Erstellt am 19. Juni 2008
    Geliefert am 25. Juni 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The building contract dated 3 july 2007 made between golden living limited and strata construction limited see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over building contract
    Erstellt am 19. Juni 2008
    Geliefert am 25. Juni 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The building contract dated 24 april 2007 made between golden living limited and howard russell construction limited see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Apr. 2008
    Geliefert am 26. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H north riding garages eastgate pickering north yorkshire t/no NYK80032 and NYK141292 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any legal licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Feb. 2008
    Geliefert am 22. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H the depot haltwistle northumberland t/n ND148444 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any legal licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Jan. 2008
    Geliefert am 05. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at newgate street cottingham east yorkshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Dez. 2007
    Geliefert am 22. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the dale, haltwistle, northumberland. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Nov. 2007
    Geliefert am 30. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at park road haltwistle northumberland t/n ND133872. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 04. Jan. 2007
    Geliefert am 10. Jan. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H former builders yard bigby street brigg north lincolnshire t/n HS273158. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 11. Aug. 2006
    Geliefert am 23. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H - land at guisborough road, nunthorpe. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 06. März 2006
    Geliefert am 09. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. März 2006Registrierung einer Belastung (395)

    Hat GOLDEN LIVING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. März 2020Beginn der Liquidation
    27. Jan. 2021Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Michael Christian Kienlen
    3rd Floor 10 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    3rd Floor 10 South Parade
    LS1 5QS Leeds
    West Yorkshire
    Daryl Warwick
    Armstrong Watson Fairview House
    Victoria Place
    CA1 1HP Carlisle
    Cumbria
    Praktiker
    Armstrong Watson Fairview House
    Victoria Place
    CA1 1HP Carlisle
    Cumbria

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0