INVISION UK LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameINVISION UK LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 04799073
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von INVISION UK LTD?

    • Nicht spezialisierter Großhandel (46900) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
    • Managementberatungstätigkeiten außer Finanzmanagement (70229) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich INVISION UK LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Invision (Uk)
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von INVISION UK LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INVISION TECHNOLOGIES (UK) LIMITED07. Juli 200307. Juli 2003
    INVISION (TECHNOLOGIES) UK LIMITED13. Juni 200313. Juni 2003

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INVISION UK LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für INVISION UK LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erfüllung der Belastung 047990730004 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Juni 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Eintragung der Belastung 047990730007, erstellt am 15. Dez. 2021

    51 SeitenMR01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    34 SeitenAA

    legacy

    154 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    154 SeitenPARENT_ACC

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Przemek Szlachta als Geschäftsführer am 30. Sept. 2020

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Philip Benjamin Bligh als Direktor am 30. Sept. 2020

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Andrew Garnham als Sekretär am 30. Sept. 2020

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Przemek Szlachta als Sekretär am 30. Sept. 2020

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    39 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 05. Juni 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Przemek Szlachta als Direktor am 14. Jan. 2020

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Stephen John Beahan als Geschäftsführer am 14. Jan. 2020

    1 SeitenTM01

    Eintragung der Belastung 047990730006, erstellt am 21. Jan. 2020

    53 SeitenMR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    33 SeitenAA

    Ernennung von Mr Przemek Szlachta als Sekretär am 19. Juni 2019

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Stephen Barry Fenby als Sekretär am 20. Juni 2019

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Stephen Lamb als Direktor am 20. Juni 2019

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von INVISION UK LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GARNHAM, Andrew
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    Sekretär
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    275449360001
    BLIGH, Philip Benjamin
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    Geschäftsführer
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    EnglandBritish275449390001
    FENBY, Stephen Barry
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    United Kingdom
    EnglandBritish101588840001
    LAMB, Stephen
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    Geschäftsführer
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    United KingdomBritish291602760001
    FENBY, Stephen Barry
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    United Kingdom
    Sekretär
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    United Kingdom
    British101588840001
    JOHNSON, Sharon
    Fieldwood House
    Haughley Green
    IP14 3RG Stowmarket
    Suffolk
    Sekretär
    Fieldwood House
    Haughley Green
    IP14 3RG Stowmarket
    Suffolk
    British124047220001
    PHILLIPS, John Joseph
    Broadview Farm
    Lower Farm Road Ringshall
    IP14 2JF Stowmarket
    Suffolk
    Sekretär
    Broadview Farm
    Lower Farm Road Ringshall
    IP14 2JF Stowmarket
    Suffolk
    British73150260001
    RAVEN, Paul
    Raven House
    55 Out Risbygate
    IP33 3RQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    Sekretär
    Raven House
    55 Out Risbygate
    IP33 3RQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    British94728430001
    SZLACHTA, Przemek
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    Sekretär
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    259992310001
    KPSK ACCOUNTS & TAX LIMITED
    1 Langham Grange
    Langham
    IP31 3EE Bury St. Edmunds
    Suffolk
    Sekretär
    1 Langham Grange
    Langham
    IP31 3EE Bury St. Edmunds
    Suffolk
    103957360001
    QA REGISTRARS LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    900018500001
    BAILEY, Anthony Michael George
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    Geschäftsführer
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    EnglandBritish158913060001
    BEAHAN, Stephen John
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    United Kingdom
    EnglandBritish91874520003
    CULLEY, Nicholas David
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    United Kingdom
    EnglandBritish112395720002
    SZLACHTA, Przemek
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    Geschäftsführer
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    EnglandBritish,Polish248632840001
    SZLACHTA, Przemek
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    Geschäftsführer
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Invision (Uk)
    EnglandBritish,Polish248632840001
    QA NOMINEES LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    900018490001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INVISION UK LTD?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Midwich Ltd
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Vinces Road
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Vinces Road
    IP22 4YT Diss
    Vinces Road
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandUk
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortUk
    Registrierungsnummer01436289
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat INVISION UK LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 15. Dez. 2021
    Geliefert am 16. Dez. 2021
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    None.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Agent
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2021Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 21. Jan. 2020
    Geliefert am 21. Jan. 2020
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc UK Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Jan. 2020Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 20. Dez. 2013
    Geliefert am 23. Dez. 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    The company, with full title guarantee, and as security for the payment and discharge of the debt, charges, amongst other things:-. (A) by way of legal mortgage, all freehold (including commonhold) and leasehold land now vested in the company together with all buildings fixtures, fittings and fixed plant and machinery now or at any time afterwards on it. This includes (without limitation) the land described or referred to in part I of the first schedule of the debenture subject only to the other mortgages or matters (if any) mentioned in part 2 of the first schedule of the debenture.. (B) by way of first fixed charge, the chattels (including all additions and improvements to, and replacements of, them from time to time), securities, intellectual property and/or other property mentioned in the second schedule of the debenture.. (C) by way of first fixed charge (except as already charged above):-. (I) all the present and future right, title and interest of the company in or to any freehold (including commonhold) or leasehold land or other immovable property wherever situated and all fixtures, fittings and fixed plant and machinery now or at any time afterwards on it.. (Ii) all letters patent, trademarks, service marks, designs, utility models, copyrights, design rights, applications for registration of any of them and the right to apply for them in any part of the world. In addition, moral rights, inventions, confidential information, know-how and rights of a similar nature arising or subsisting anywhere in the world in relation to all or any of the above (whether registered or unregistered) now or at any time afterwards belonging to the company (together with any of the same mentioned in the second schedule of the debenture, collectively called the "intellectual property").. All defined terms as defined in the debenture.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 20. Dez. 2013
    Geliefert am 23. Dez. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    All assets debenture. The company charges and agrees to charge all of its present and future right, title and interest in and to the following assets which are at any time owned by the company, or in which it from time to time has an interest:. 1.1.1 by way of first legal mortgage all real property (if any) at the date of the debenture vested in, or charged to, the company;. 1.1.2 by way of first fixed charge:. 1.1.2.1 all real property and all interests in real property (not charged by clause 1.1.1);. 1.1.2.2 all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. 1.1.2.3 the proceeds of sale of all real property;. 1.1.3 by way of first fixed charge all intellectual property owned by the company.. All defined terms as defined in the debenture.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 02. Sept. 2022Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 20. Dez. 2013
    Geliefert am 23. Dez. 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Assignment. Notification of addition to or amendment of charge.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 16. Aug. 2010
    Geliefert am 21. Aug. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of accession and charge
    Erstellt am 19. Nov. 2009
    Geliefert am 08. Dez. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Jan. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0