INVISION UK LTD
Überblick
| Unternehmensname | INVISION UK LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 04799073 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von INVISION UK LTD?
- Nicht spezialisierter Großhandel (46900) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Managementberatungstätigkeiten außer Finanzmanagement (70229) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich INVISION UK LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Invision (Uk) Vinces Road IP22 4YT Diss |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von INVISION UK LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| INVISION TECHNOLOGIES (UK) LIMITED | 07. Juli 2003 | 07. Juli 2003 |
| INVISION (TECHNOLOGIES) UK LIMITED | 13. Juni 2003 | 13. Juni 2003 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INVISION UK LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für INVISION UK LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erfüllung der Belastung 047990730004 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Eintragung der Belastung 047990730007, erstellt am 15. Dez. 2021 | 51 Seiten | MR01 | ||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 34 Seiten | AA | ||
legacy | 154 Seiten | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||
legacy | 154 Seiten | PARENT_ACC | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Przemek Szlachta als Geschäftsführer am 30. Sept. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Philip Benjamin Bligh als Direktor am 30. Sept. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Ernennung von Mr Andrew Garnham als Sekretär am 30. Sept. 2020 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Przemek Szlachta als Sekretär am 30. Sept. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 39 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Ernennung von Mr Przemek Szlachta als Direktor am 14. Jan. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Stephen John Beahan als Geschäftsführer am 14. Jan. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Eintragung der Belastung 047990730006, erstellt am 21. Jan. 2020 | 53 Seiten | MR01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 33 Seiten | AA | ||
Ernennung von Mr Przemek Szlachta als Sekretär am 19. Juni 2019 | 2 Seiten | AP03 | ||
Beendigung der Bestellung von Stephen Barry Fenby als Sekretär am 20. Juni 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Mr Stephen Lamb als Direktor am 20. Juni 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von INVISION UK LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARNHAM, Andrew | Sekretär | Vinces Road IP22 4YT Diss Invision (Uk) | 275449360001 | |||||||
| BLIGH, Philip Benjamin | Geschäftsführer | Vinces Road IP22 4YT Diss Invision (Uk) | England | British | 275449390001 | |||||
| FENBY, Stephen Barry | Geschäftsführer | Vinces Road IP22 4YT Diss Invision (Uk) United Kingdom | England | British | 101588840001 | |||||
| LAMB, Stephen | Geschäftsführer | Vinces Road IP22 4YT Diss Invision (Uk) | United Kingdom | British | 291602760001 | |||||
| FENBY, Stephen Barry | Sekretär | Vinces Road IP22 4YT Diss Invision (Uk) United Kingdom | British | 101588840001 | ||||||
| JOHNSON, Sharon | Sekretär | Fieldwood House Haughley Green IP14 3RG Stowmarket Suffolk | British | 124047220001 | ||||||
| PHILLIPS, John Joseph | Sekretär | Broadview Farm Lower Farm Road Ringshall IP14 2JF Stowmarket Suffolk | British | 73150260001 | ||||||
| RAVEN, Paul | Sekretär | Raven House 55 Out Risbygate IP33 3RQ Bury St Edmunds Suffolk | British | 94728430001 | ||||||
| SZLACHTA, Przemek | Sekretär | Vinces Road IP22 4YT Diss Invision (Uk) | 259992310001 | |||||||
| KPSK ACCOUNTS & TAX LIMITED | Sekretär | 1 Langham Grange Langham IP31 3EE Bury St. Edmunds Suffolk | 103957360001 | |||||||
| QA REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | The Studio St Nicholas Close WD6 3EW Elstree Hertfordshire | 900018500001 | |||||||
| BAILEY, Anthony Michael George | Geschäftsführer | Vinces Road IP22 4YT Diss Invision (Uk) | England | British | 158913060001 | |||||
| BEAHAN, Stephen John | Geschäftsführer | Vinces Road IP22 4YT Diss Invision (Uk) United Kingdom | England | British | 91874520003 | |||||
| CULLEY, Nicholas David | Geschäftsführer | Vinces Road IP22 4YT Diss Invision (Uk) United Kingdom | England | British | 112395720002 | |||||
| SZLACHTA, Przemek | Geschäftsführer | Vinces Road IP22 4YT Diss Invision (Uk) | England | British,Polish | 248632840001 | |||||
| SZLACHTA, Przemek | Geschäftsführer | Vinces Road IP22 4YT Diss Invision (Uk) | England | British,Polish | 248632840001 | |||||
| QA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | The Studio St Nicholas Close WD6 3EW Elstree Hertfordshire | 900018490001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INVISION UK LTD?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midwich Ltd | 06. Apr. 2016 | Vinces Road IP22 4YT Diss Vinces Road United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat INVISION UK LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 15. Dez. 2021 Geliefert am 16. Dez. 2021 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung None. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 21. Jan. 2020 Geliefert am 21. Jan. 2020 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 20. Dez. 2013 Geliefert am 23. Dez. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung The company, with full title guarantee, and as security for the payment and discharge of the debt, charges, amongst other things:-. (A) by way of legal mortgage, all freehold (including commonhold) and leasehold land now vested in the company together with all buildings fixtures, fittings and fixed plant and machinery now or at any time afterwards on it. This includes (without limitation) the land described or referred to in part I of the first schedule of the debenture subject only to the other mortgages or matters (if any) mentioned in part 2 of the first schedule of the debenture.. (B) by way of first fixed charge, the chattels (including all additions and improvements to, and replacements of, them from time to time), securities, intellectual property and/or other property mentioned in the second schedule of the debenture.. (C) by way of first fixed charge (except as already charged above):-. (I) all the present and future right, title and interest of the company in or to any freehold (including commonhold) or leasehold land or other immovable property wherever situated and all fixtures, fittings and fixed plant and machinery now or at any time afterwards on it.. (Ii) all letters patent, trademarks, service marks, designs, utility models, copyrights, design rights, applications for registration of any of them and the right to apply for them in any part of the world. In addition, moral rights, inventions, confidential information, know-how and rights of a similar nature arising or subsisting anywhere in the world in relation to all or any of the above (whether registered or unregistered) now or at any time afterwards belonging to the company (together with any of the same mentioned in the second schedule of the debenture, collectively called the "intellectual property").. All defined terms as defined in the debenture.. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 20. Dez. 2013 Geliefert am 23. Dez. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All assets debenture. The company charges and agrees to charge all of its present and future right, title and interest in and to the following assets which are at any time owned by the company, or in which it from time to time has an interest:. 1.1.1 by way of first legal mortgage all real property (if any) at the date of the debenture vested in, or charged to, the company;. 1.1.2 by way of first fixed charge:. 1.1.2.1 all real property and all interests in real property (not charged by clause 1.1.1);. 1.1.2.2 all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. 1.1.2.3 the proceeds of sale of all real property;. 1.1.3 by way of first fixed charge all intellectual property owned by the company.. All defined terms as defined in the debenture.. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 20. Dez. 2013 Geliefert am 23. Dez. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Assignment. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 16. Aug. 2010 Geliefert am 21. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession and charge | Erstellt am 19. Nov. 2009 Geliefert am 08. Dez. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0